TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.

TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC061912
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    • (4521) /

    ¿Dónde se encuentra TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    Dirección de la sede social
    c/o HASTINGS & CO
    82 Mitchell Street
    G1 3NA Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    A TULLOCH & SONS LIMITED04 nov 198604 nov 1986
    DONALD DAVIDSON (PLUMBING AND HEATING) LIMITED11 mar 197711 mar 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de reunión final de acreedores

    3 páginas4.17(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de 151 st Vincent Street Glasgow G2 5NJ el 28 feb 2012

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de William Thomas Mackay como director el 12 ene 2010

    2 páginasTM01

    Aviso de orden judicial de liquidación

    1 páginasCO4.2(Scot)

    Notificación de la orden de liquidación

    1 páginas4.2(Scot)

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Garvis Snook como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sandra Al-Kordi como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ashley Martin como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Sandra Joan Al-Kordi como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de John Mackay como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Julian Turnbull como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Scott Alexander como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 mar 2010

    Estado de capital el 15 mar 2010

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cambio de datos del director Scott Alexander el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director William Thomas Mackay el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Thomas Macleod como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Grant Lowe como director

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AL-KORDI, Sandra Joan
    151 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5NJ
    Secretario
    151 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5NJ
    154058120001
    CAMPBELL, Gary Angus
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    Secretario
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    British44913110001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Secretario
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    British565690001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Flat 4/1, 255 Clarence Drive
    G11 7JU Glasgow
    Secretario
    Flat 4/1, 255 Clarence Drive
    G11 7JU Glasgow
    BritishSolicitor87534020001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secretario
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    BritishChartered Accountant1321720003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secretario
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    BritishChartered Accountant1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secretario
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Secretario
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    ALEXANDER, Scott
    Ruchlinn
    Camp Road,
    PH6 2HA Comrie
    Perthshire
    Director
    Ruchlinn
    Camp Road,
    PH6 2HA Comrie
    Perthshire
    ScotlandBritishGroup Commercial Director85764980001
    BEVERIDGE, William John
    Drummoyne
    Kiltarlity
    IV4 7HT Beauly
    Inverness Shire
    Director
    Drummoyne
    Kiltarlity
    IV4 7HT Beauly
    Inverness Shire
    BritishCivil Engineer25882680001
    BLACKBURN, Peter
    4 Kinkell
    IV7 8HY Dingwall
    Highland
    Director
    4 Kinkell
    IV7 8HY Dingwall
    Highland
    BritishCommercial Director25882700001
    CAMERON, Kenneth William
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    Director
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    ScotlandBritishCivil Engineer41410280001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Director
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Director
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritishChartered Surveyor50219540001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Director
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    BritishFinance Director107801990001
    HARRISON, Peter John
    Washington House Viewfield Street
    IV12 4HW Nairn
    Director
    Washington House Viewfield Street
    IV12 4HW Nairn
    BritishChartered Accountant43281820001
    HENDERSON, John Brodie
    5 Drummond Place
    IV2 4JT Inverness
    Inverness Shire
    Director
    5 Drummond Place
    IV2 4JT Inverness
    Inverness Shire
    BritishCivil Engineer69260990002
    HILDITCH, Alan Thomas
    3 Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    Scotland
    Director
    3 Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    Scotland
    BritishQuantity Surveyor75340740001
    JAMIESON, John Ian
    76 Airyhall Drive
    AB15 7QB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    76 Airyhall Drive
    AB15 7QB Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishQuantity Surveyor68172620001
    LOWE, Grant Barrington
    Glaick Of Kessock
    North Kessock
    IV1 1XG Inverness
    Highland
    Scotland
    Director
    Glaick Of Kessock
    North Kessock
    IV1 1XG Inverness
    Highland
    Scotland
    BritishQuantity Surveyor49961400001
    MACFARLANE, John
    Riverside
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    Director
    Riverside
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    ScotlandBritishCompany Director411010001
    MACFARLANE, Neil John
    Rosebank
    Springfield
    IV51 9LX Portree
    Isle Of Skye
    Director
    Rosebank
    Springfield
    IV51 9LX Portree
    Isle Of Skye
    BritishCompany Director411020001
    MACKAY, John
    18 Cameron Road
    IV19 1NN Tain
    Ross Shire
    Director
    18 Cameron Road
    IV19 1NN Tain
    Ross Shire
    United KingdomBritishChartered Accountant68554680001
    MACKAY, William Thomas
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    Director
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritishDirector31116810002
    MACKAY, William Thomas
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    Director
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritishCommercial Director31116810002
    MACKENZIE, Donald Henry
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    Director
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishConstruction Director66483050001
    MACLEOD, Norman
    1 Glebe Lane
    Newton Mearns
    G77 6DS Glasgow
    Director
    1 Glebe Lane
    Newton Mearns
    G77 6DS Glasgow
    BritishCommercial Manager54906040001
    MACLEOD, Thomas
    4 Enrick Crescent
    Glenview, Drumnadrochit
    IV63 6TP Highland
    Director
    4 Enrick Crescent
    Glenview, Drumnadrochit
    IV63 6TP Highland
    BritishContracts Manager94117610001
    MACMORRAN, James George Harley
    84 Myreside Road
    EH10 5BZ Edinburgh
    Director
    84 Myreside Road
    EH10 5BZ Edinburgh
    BritishChartered Quantity Surveyor54477250001
    MARTIN, Ashley Graham
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector116805870001
    MCLEOD, William Lind
    32 Mansewood Road
    G43 1TN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    32 Mansewood Road
    G43 1TN Glasgow
    Lanarkshire
    BritishEngineer37035550001
    MCMAHON, Michael
    3 Tinto Drive
    Balloch
    G68 9BF Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    3 Tinto Drive
    Balloch
    G68 9BF Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishCompany Director102736560001
    MCMENAMIN, Joseph
    27 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SB Glasgow
    Director
    27 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SB Glasgow
    BritishCivil Engineer42344560001
    MEIKLE, Stewart Robert
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    Director
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    ScotlandBritishCommercial Director70911700001
    PHILIP, David Fraser
    27 Wyvis Road
    IV12 5NR Nairn
    Morayshire
    Director
    27 Wyvis Road
    IV12 5NR Nairn
    Morayshire
    BritishChartered Surveyor567450001

    ¿Tiene TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 12 nov 1997
    Entregado el 19 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 nov 1997Registro de un cargo (410)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 25 sept 1996
    Entregado el 04 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 oct 1996Registro de un cargo (410)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 28 jul 1994
    Entregado el 17 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All and whole that roughly triangular shaped piece of ground at sluggans, dunvegan road,portree,isle of skye.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 17 ago 1994Registro de un cargo (410)
    • 28 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 nov 1993
    Entregado el 17 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 nov 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 22 mar 1990
    Entregado el 05 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 abr 1990Registro de una carga
    • 29 nov 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    02 nov 2012Fecha de disolución
    17 ene 2012Fecha de la petición
    31 jul 2012Conclusión de la liquidación
    17 ene 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0