CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED

CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC062818
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1st Floor 4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence14 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 31 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    8 páginasAA

    Modification des détails de Campbell Lee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 nov 2023

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Sirius Building the Clocktower South Gyle Crescent Edinburgh EH12 9LB a 1st Floor 4-5 Lochside Avenue Edinburgh EH12 9DJ el 10 nov 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    Declaración de confirmación presentada el 31 may 2022 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    46 páginasPARENT_ACC

    Declaración de confirmación presentada el 31 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019

    19 páginasAA

    legacy

    43 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 31 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Robert Andrew Coupland como director el 28 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Niclas Sanfridsson como director el 01 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018

    15 páginasAA

    legacy

    41 páginasPARENT_ACC

    ¿Quiénes son los directivos de CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PETZER, Bradley
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    Secretario
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    237985880001
    COUPLAND, Robert Andrew
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    Director
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    United KingdomBritishDirector138313750002
    PETZER, Bradley Mark
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    Director
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    United KingdomBritishDirector82998740004
    CLARK, Simon Timothy
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    Secretario
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    BritishCompany Director113817820001
    FREW, Stephen
    5 Malcolm Street
    ML1 3HY Motherwell
    Lanarkshire
    Secretario
    5 Malcolm Street
    ML1 3HY Motherwell
    Lanarkshire
    BritishAccountant83387180002
    GOLDWATER, Andrew Geoffrey
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Secretario
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    202001060001
    KERRY, Rebecca Jade
    Camelon Road
    Arnothill
    FK1 5RX Falkirk
    16
    Stirlingshire
    United Kingdom
    Secretario
    Camelon Road
    Arnothill
    FK1 5RX Falkirk
    16
    Stirlingshire
    United Kingdom
    BritishFinancial Director130236210001
    LEE, James
    11 Oakridge Road
    G69 7TH Drumpellier Lawns
    Bargeddie
    Secretario
    11 Oakridge Road
    G69 7TH Drumpellier Lawns
    Bargeddie
    British38693080005
    MACKENZIE, Graeme George
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    Secretario
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    209147680001
    BIRD SEMPLE FYFE IRELAND
    Orchard Brae House 30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Midlothian
    Secretario corporativo
    Orchard Brae House 30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Midlothian
    1171800001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secretario corporativo
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    ADAMSON, Conrad Falconer Patterson
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    Director
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    BritishConsultant340760001
    AITON, Archie John
    16 Manor Place
    EH3 7DS Edinburgh
    Director
    16 Manor Place
    EH3 7DS Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Accountant34031830001
    CAMPBELL, Atholl Stuart
    Fernhill
    PH10 7JL Bridge Of Cally
    Perthshire
    Director
    Fernhill
    PH10 7JL Bridge Of Cally
    Perthshire
    BritishComputer Consultant1351280001
    CLARK, Simon Timothy
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    Director
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director113817820001
    FREW, Stephen
    5 Malcolm Street
    ML1 3HY Motherwell
    Lanarkshire
    Director
    5 Malcolm Street
    ML1 3HY Motherwell
    Lanarkshire
    BritishAccountant83387180002
    GIBB, Iain Millar
    52 Thistle Avenue
    FK3 8YQ Grangemouth
    Stirlingshire
    Director
    52 Thistle Avenue
    FK3 8YQ Grangemouth
    Stirlingshire
    BritishComputer Consultant495920001
    GOLDWATER, Andrew Geoffrey
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Director
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    EnglandBritishFinance Director215773250001
    HOWLING, Mark Ian
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    Director
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    United KingdomBritishDirector71889290003
    HYSLOP, Maitland Peter, Mr.
    5 Elvaston Grove
    NE46 2HR Hexham
    Northumberland
    Director
    5 Elvaston Grove
    NE46 2HR Hexham
    Northumberland
    EnglandBritishDirector47679130003
    KELLY, William Birrell
    64 Stirling Road
    Larbert
    FK5 4NF Falkirk
    Stirlingshire
    Director
    64 Stirling Road
    Larbert
    FK5 4NF Falkirk
    Stirlingshire
    ScotlandBritishCompany Director172872650001
    KERRY, Rebecca Jade
    Camelon Road
    Arnothill
    FK1 5RX Falkirk
    16
    Stirlingshire
    United Kingdom
    Director
    Camelon Road
    Arnothill
    FK1 5RX Falkirk
    16
    Stirlingshire
    United Kingdom
    British130236210001
    LEE, James
    11 Oakridge Road
    G69 7TH Drumpellier Lawns
    Bargeddie
    Director
    11 Oakridge Road
    G69 7TH Drumpellier Lawns
    Bargeddie
    BritishConsultant38693080005
    LEE, James
    6 Leighton Court
    FK15 0ED Dunblane
    Director
    6 Leighton Court
    FK15 0ED Dunblane
    BritishComputer Consultant38693080001
    MACKENZIE, Graeme George
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    Director
    Rose Kiln Lane
    RG2 0HP Reading
    Cadogan House
    England
    ScotlandBritishDirector160949340001
    MUIRHEAD, Gavin Stewart
    10 Dornoch Way
    G68 0JA Cumbernauld
    North Lanarkshire
    Director
    10 Dornoch Way
    G68 0JA Cumbernauld
    North Lanarkshire
    ScotlandBritishManaging Director58227270001
    QUINN, Charles William
    10 Brierie Hill Grove
    Crosslee
    PA6 7BW Johnstone
    Renfrewshire
    Director
    10 Brierie Hill Grove
    Crosslee
    PA6 7BW Johnstone
    Renfrewshire
    BritishSales And Marketing Director64185150001
    REES, Alun William
    4 Hogarth Drive
    KY15 5YH Cupar
    Fife
    Director
    4 Hogarth Drive
    KY15 5YH Cupar
    Fife
    BritishCompany Director56367760001
    SANFRIDSSON, Niclas
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Director
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    EnglandSwedishDirector237983000001
    STEPHENSON, Neil
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    Director
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director70252230011
    TOAL, John
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    Director
    The Clocktower
    South Gyle Crescent
    EH12 9LB Edinburgh
    Sirius Building
    Scotland
    United KingdomBritishDirector172883390001
    WAITE, Alastair
    Woodcroft
    Clack Lane
    DL6 3PP Osmotherly
    North Yorkshire
    Director
    Woodcroft
    Clack Lane
    DL6 3PP Osmotherly
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director77706100005
    YACOUBIAN, Edward
    34 Tannoch Drive
    Milngavie
    G62 8AS Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    34 Tannoch Drive
    Milngavie
    G62 8AS Glasgow
    Lanarkshire
    BritishComputer Consultant495930001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Campbell Lee Limited
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    06 abr 2016
    4-5 Lochside Avenue
    EH12 9DJ Edinburgh
    1st Floor
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalScottish
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registroSc145587
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CAMPBELL LEE COMPUTER SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 jun 2016
    Entregado el 21 jun 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 21 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    • 07 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 14 jun 2016
    Entregado el 20 jun 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 20 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    • 07 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 14 oct 2011
    Entregado el 25 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 25 oct 2011Registro de un cargo (MG01s)
    • 23 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 27 nov 2008
    Entregado el 05 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 05 dic 2008Registro de un cargo (410)
    • 11 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 20 abr 1995
    Entregado el 01 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All and whole that piece of ground consisting of two roods imperial measure or thereby lying in the former burgh of falkirk and county of stirling.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 01 may 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 09 dic 1987
    Entregado el 16 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease over mckinven house, meeks road, falkirk under exception.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 dic 1987Registro de una carga
    • 15 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 26 nov 1987
    Entregado el 10 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1155 1/2 square yard piece of ground lying on the north side of meeks road, falkirk.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 dic 1987Registro de una carga
    • 06 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 12 ene 1982
    Entregado el 20 ene 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 ene 1982Registro de una carga
    • 04 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0