C.G. LEASING LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | C.G. LEASING LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC062907 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de C.G. LEASING LIMITED?
- (9999) /
¿Dónde se encuentra C.G. LEASING LIMITED?
Dirección de la sede social | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WS Edinburgh |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de C.G. LEASING LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para C.G. LEASING LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Magdalena Koncikova como director el 13 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Alicia Essex como director el 13 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Hall Mcgibbon como director el 30 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Michael Jenkins como director el 30 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 27 sept 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Ann French como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Alicia Essex el 01 ene 2010 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Alicia Essex el 20 jul 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Paul Robert Johnson el 01 ene 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director John Michael Jenkins el 01 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director William Hall Mcgibbon el 01 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 10 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de C.G. LEASING LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSEX, Alicia | Secretario | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex | British | 139344890001 | ||||||
FRENCH, Ann | Secretario | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex United Kingdom | 161409160001 | |||||||
JOHNSON, Paul Robert | Secretario | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | British | 106143590001 | ||||||
ESSEX, Alicia | Director | 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 155696080001 | ||||
KONCIKOVA, Magdalena | Director | 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Slovakian | Company Director | 163324190001 | ||||
GRAY, Stephen Joseph | Secretario | 14 Penbend Mansions Chiswick High Road Chiswick W4 2LU London | American | 71089400001 | ||||||
KERSHAW, Simon John | Secretario | 40 Sandacre Road M23 1AP Manchester Lancashire | British | 106236300001 | ||||||
NICHOLSON, Judith Ann | Secretario | 15 Alkerden Road W4 2HP London | British | 27201530002 | ||||||
PATMORE, Ian Robert | Secretario | Spring Bank Farm Lodge Lane OL13 0BJ Bacup Lancashire | British | 64498630002 | ||||||
REED, Michael John Christopher | Secretario | 17 Chartwell Gardens Appleton WA4 5HZ Warrington Cheshire | British | 36285400001 | ||||||
RYLATT, Diane | Secretario | Little Bouts Farmhouse Bouts Lane Inkberrow WR7 4HP Worcester Worcestershire | British | 46068950001 | ||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
BURR, Jonathan Charles | Director | 15 Leicester Road Hale WA15 9QA Altrincham Cheshire | England | British | Managing Director | 49902210001 | ||||
CATHCART, William Alun | Director | Trade Winds Cox Green Rudgwick RH12 3DF Horsham West Sussex | British | Director | 9490580002 | |||||
CHAPMAN, Mark Andrew | Director | 3 Fern Bank WA11 8DZ Rainford Merseyside | British | Financial Director | 54283410002 | |||||
DONNELLY, Michael | Director | 10 Pownall Road SK9 5DR Wilmslow Cheshire | British | Director | 8014630002 | |||||
FARRAR, Daniel | Director | The Coach House Gravel Lane SK9 6EG Wilmslow Cheshire | British | Director | 42497200001 | |||||
GREEN, Richard William | Director | Richborough House Sandy Lane Sunningdale SL5 0ND Ascot Berkshire | British | Director | 121346530001 | |||||
HANNA, Kenneth George | Director | 5 Onslow Drive Ascot Mansions SL5 7UL North Ascot Berkshire | British | Director | 78515410001 | |||||
JENKINS, John Michael | Director | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | England | British | Director | 115008010001 | ||||
LOMAS, Paul John | Director | 12 Burwardsley Way Kingsmead CW9 8WN Northwich Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 127596100001 | ||||
MARSDEN, Andrew Neil | Director | 302 London Road Appleton WA4 5DR Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Finance Director | 75914530001 | ||||
MARSDEN, Andrew Neil | Director | 302 London Road Appleton WA4 5DR Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Finance Director | 75914530001 | ||||
MCAULEY, Steven Joseph | Director | 3 Barnswood Close WA4 2YJ Grappenhall Warrington | British | Commercial Director | 88278760003 | |||||
MCGIBBON, William Hall | Director | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | Company Director | 131612680004 | ||||
NICHOLSON, Judith Ann | Director | 15 Alkerden Road W4 2HP London | England | British | Director | 27201530002 | ||||
PAREKH, Girish | Director | Fairhaven 1 Kings Drive Fulwood PR2 3HN Preston | British | Financial Director | 84067630001 | |||||
REED, Michael John Christopher | Director | 17 Chartwell Gardens Appleton WA4 5HZ Warrington Cheshire | British | Customer Service Director | 36285400001 | |||||
RUEGG, Rolf | Director | Bonnletstrasse 7 G-7891 Lottstetten Germany | Swiss | Director | 29746290001 | |||||
TAYLOR, Steven Michael | Director | 13 Victoria Avenue Didsbury M20 2GY Manchester | British | Managing Director | 68164080001 | |||||
TAYLOR, Timothy John | Director | 4 Thorngrove Road SK9 1DD Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | Director | 42497260001 | ||||
TEALE, David Stanley | Director | 1 Lovedale Avenue EH14 7DT Balerno Midlothian | British | Leasing Consultant | 5553830001 | |||||
VILLAMULTEDO, Massimo | Director | 42 Church Road SW19 5AN Wimbledon | Italian | Company Director | 110734660002 | |||||
ZAFIROVSKI, Mike Svetozar | Director | 19740 Sweetwater Curve Shorewood Minnesota 55331 Usa | American | Director | 54697260001 |
¿Tiene C.G. LEASING LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture 1ST fixed charge | Creado el 26 oct 1990 Entregado el 12 nov 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Estates, rights, interests in freehold and leasehold property book debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 03 ago 1990 Entregado el 24 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 09 mar 1987 Entregado el 23 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole right, title and interest of the company to the lessees part of hiring or leasing agreements. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Debenture | Creado el 31 mar 1986 Entregado el 10 abr 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All right, title and interest of the company in respect of all motor vehicles, and the benefit of all contracts for the hire or lease of motor vehicles. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Floating charge | Creado el 25 nov 1985 Entregado el 11 dic 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All monies or payments due to the company from lining or purchase agreements. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creado el 29 sept 1983 Entregado el 07 oct 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Floating charge | Creado el 23 mar 1981 Entregado el 06 abr 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0