THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC068249 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
- Actividades de clubes deportivos (93120) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3 Castlehill Lane Symington ML12 6SJ Biggar Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CENTRAL SCOTLAND CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED | 04 jun 1979 | 04 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Louise Joy Mccutcheon como director el 21 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de Louise Joy Mccutcheon en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 oct 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Jamie Gordon March en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 sept 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2024 | 3 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Newmains Cottages Whitekirk North Berwick EH39 5PR Scotland a 3 Castlehill Lane Symington Biggar ML12 6SJ el 09 sept 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Notification de Mark Dougan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 sept 2025 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark Dougan el 30 ago 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Catherine Duff como director el 15 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Morag Ann Spence como director el 15 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Allison Mcculloch como director el 15 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark Dougan el 15 feb 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Mark Dougan como director el 15 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Susan Jane Don como director el 15 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Eileen Joyce Cornish como director el 15 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Eileen Joyce Cornish como secretario el 15 feb 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Jamie Gordon March en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Springfield Farm Langlees Road Biggar ML12 6NP Scotland a 2 Newmains Cottages Whitekirk North Berwick EH39 5PR el 21 feb 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Ms Sheila Mcneill el 17 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ms Sanchia Karen May el 17 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Susan Jane Don el 17 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Colin James Smith como director el 17 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTRAM, Ian | Director | 7 Houston Mains Uphall EH52 6JU Broxburn West Lothian | Scotland | British | 51824330001 | |||||
| DOUGAN, Mark | Director | Castlehill Lane Symington ML12 6SJ Biggar 3 Scotland | United Kingdom | British | 332403560002 | |||||
| DUFF, Catherine | Director | Newton Meadows Wamphray DG10 9NX Moffat 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 332441150001 | |||||
| MARCH, Jamie Gordon | Director | Newmains Cottages Whitekirk EH39 5PR North Berwick 2 Scotland | Scotland | British | 264789000001 | |||||
| MAY, Sanchia Karen | Director | Kinellar AB21 0TT Aberdeen Woodside Croft Scotland | Scotland | British | 235512240001 | |||||
| MCARTHUR, Graeme Victor | Director | Dolphinton EH46 7HH West Linton Westmill Farm Scotland | Scotland | British | 158098100001 | |||||
| MCCULLOCH, Allison | Director | Drumclog ML10 6QQ Strathaven Station Cottage Scotland | Scotland | British | 332404050001 | |||||
| MCNEILL, Sheila | Director | Parkgate DG1 3NF Dumfries Dalfibble United Kingdom | United Kingdom | British | 198567960002 | |||||
| SPENCE, Morag Ann | Director | St Mays Holm KW17 2RU Orkney Ingleneuk Scotland | Scotland | British | 332404160001 | |||||
| VASS, Sharron, Dr | Director | Main Street EH46 7EA West Linton Old Manor House Scotland | Scotland | British | 306299320001 | |||||
| COLVILLE, Deirdre Joan | Secretario | Islabank PH13 9HL Coupar Angus Perthshire | British | 1161580001 | ||||||
| CORNISH, Eileen Joyce | Secretario | Alice Hamilton Way EH46 7EX West Linton 21 Scotland | 310779690001 | |||||||
| CORNISH, Eileen | Secretario | Alice Hamilton Way West Linton 21 Scotland | 255604660001 | |||||||
| JEFFREY, George Johnstone | Secretario | West Halket Lugton KA3 4EE Kilmarnock Ayrshire | British | 95980003 | ||||||
| MCCLOY, Caroline | Secretario | 1 Cowan Street Hillhead G12 8PF Glasgow Lanarkshire | British | 51824220001 | ||||||
| MCFARLANE, John Keir, Secretary | Secretario | Rattray PH10 7HQ Blairgowrie Easter Rattray House Perthshire United Kingdom | British | 135218780001 | ||||||
| MCNEILL, Sheila | Secretario | Langlees Road ML12 6NP Biggar Springfield Farm Scotland | 283443240001 | |||||||
| RUSHTON GREEN, Ann | Secretario | Blawearie Cottage The Wells DD8 5LZ Denholm Hawick | British | 44954400002 | ||||||
| RUSSELL, David | Secretario | Turin DD8 2UF Forfar Turin East Lodge Angus Scotland | 198414890001 | |||||||
| SMITH, Andrew | Secretario | 11 Hamilton Park North Bothwell Road ML3 0FG Hamilton Lanarkshire | British | 69033290002 | ||||||
| THORNTON-KEMSLEY, Alison Clare | Secretario | Thornton AB30 1EB Laurencekirk Kincardineshire Scotland | British | 17895340001 | ||||||
| THORNTON-KEMSLEY, Nigel Scott | Secretario | Thornton Castle AB30 1EB Laurencekirk Kincardineshire | British | 37250001 | ||||||
| BARRON, Audrey Elizabeth | Director | West Newton Arbroath DD11 5RQ Arbroath Angus | Scotland | British | 84498550001 | |||||
| BARRON, Patrick Marcus Stanislaw | Director | Leroch Farm Alyth PH10 6TB Blairgowrie Perthshire | British | 80871820001 | ||||||
| BINNEY, Elizabeth | Director | Keithick PH13 9NF Coupar Angus Perthshire | British | 39993910001 | ||||||
| BLAIR IMRIE, Hew | Director | Lunan Farm Lunan Bay DD11 5ST Arbroath Angus | British | 44954440001 | ||||||
| BLAIR IMRIE, Hew | Director | Lunan Farm Lunan Bay DD11 5ST Arbroath Angus | British | 44954440001 | ||||||
| BOSANQUET, Campbell Claude | Director | Kingswood Walk Kingswells AB15 8AG Aberdeen Redmarshall / 6 United Kingdom | Scotland | British | 128079170001 | |||||
| BROWN, David | Director | 166 Coupar Angus Road Birkhill DD2 5PG Dundee Avonlea Tayside Scotland | Scotland | British | 161341510001 | |||||
| BROWN, David | Director | 166 Coupar Angus Road Birkhill DD2 5PG Dundee Avonlea Tayside Scotland | United Kingdom | British | 161369910001 | |||||
| BROWN, Michael | Director | Leuchlands DD9 7PL Brechin Ellie Cottage Angus Scotland | Scotland | British | 161341470001 | |||||
| BROWN, Michael | Director | Leuchlands DD9 7PL Brechin Ellie Cottage Angus Scotland | Scotland | British | 161352350001 | |||||
| BROWN, Michael Raymond | Director | Myreside East Myreside Falkland Fife Uk | Scotland | British | 25908600002 | |||||
| CHAMBERS, Ishbel Mary | Director | Immeroin Blairgowrie Road PH13 9HW Coupar Angus Perthshire | British | 4963710001 | ||||||
| COLVILLE, Deirdre Joan | Director | Islabank PH13 9HL Coupar Angus Perthshire | British | 1161580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE SCOTTISH CARRIAGE DRIVING ASSOCIATION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Mark Dougan | 09 sept 2025 | Castlehill Lane Symington ML12 6SJ Biggar 3 Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Jamie Gordon March | 17 feb 2024 | Newmains Cottages Whitekirk EH39 5PR North Berwick 2 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Louise Joy Mccutcheon | 21 may 2023 | Castlehill Lane Symington ML12 6SJ Biggar 3 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Louise Mccutcheon | 16 feb 2019 | Langlees Road ML12 6NP Biggar Springfield Farm Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr David Russell | 06 abr 2016 | Turin DD8 2UF Forfar Turin East Lodge Angus | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0