SCOTMIN NUTRITION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTMIN NUTRITION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC068567 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
- Fabricación de alimentos preparados para animales de granja (10910) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Dirección de la sede social | 13 Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr South Ayrshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROBERTSON MCGAWN LIMITED | 14 jun 1979 | 14 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 22 jun 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 sept 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Thomas Dalton como director el 21 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 sept 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Ratcliffe como secretario el 25 nov 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Katie Wood como secretario el 25 nov 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Robert Hutchison East Bridge Kirkcaldy Fife KY1 2SR a 13 Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate Ayr South Ayrshire KA8 9RX el 20 oct 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy John Davies el 23 sept 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Thomas Dalton el 23 sept 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Katie Sinclair el 19 ene 2016 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 ago 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 ago 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATCLIFFE, Matthew | Secretario | Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr 13 South Ayrshire Scotland | 219613430001 | |||||||
| AUSTIN, Neil | Director | Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr 13 South Ayrshire Scotland | England | British | 178039060001 | |||||
| DAVIES, Timothy John | Director | Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr 13 South Ayrshire Scotland | United Kingdom | British | 191543920001 | |||||
| MCGAWN, James Clement | Secretario | 14 Guiltreehill Alloway KA7 4XG Ayr Ayrshire | British | 68490001 | ||||||
| MCGRATH, Michael James | Secretario | 2 Weatherhouse Cottages Bowhill TD7 5HE Selkirk | British | 61790430001 | ||||||
| ROBERTSON, Andrew James | Secretario | 18 Ailsa Street KA9 1RH Prestwick Ayrshire | British | 109649810001 | ||||||
| RUNCIMAN, Arthur Alan | Secretario | 4 Marlepark Alloway KA7 4RN Ayr Ayrshire | British | 115364670001 | ||||||
| WOOD, Katie | Secretario | Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr 13 South Ayrshire Scotland | British | 175331670002 | ||||||
| WOOD, Ronald Chalmers | Secretario | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | British | 157428160001 | ||||||
| ANDERSON, Michele-Ange | Director | 2 Magdala Crescent EH12 5BE Edinburgh Midlothian | British | 108620320001 | ||||||
| BRUCE, William Raymond | Director | 27 Argyle Street Rothesay PA20 0AX Bute Isle Of Bute | British | 12000004 | ||||||
| CLARKE, Michael Drummond | Director | Nether Stewarton Eddleston EH45 8PP Peebles | United Kingdom | British | 89140100001 | |||||
| DALE, Trevor Neil | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | United Kingdom | British | 126864230001 | |||||
| DALTON, Ian Thomas | Director | Whitfield Drive Heathfield Industrial Estate KA8 9RX Ayr 13 South Ayrshire Scotland | United Kingdom | British | 77912790002 | |||||
| HENDERSON, Ian Robert | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | Scotland | British | 41575410001 | |||||
| HOLMES, Christopher Nigel Couper | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | England | British | 4291330002 | |||||
| LAMONT, Julian Callum | Director | 1 Brighouse Park Court Cramond EH4 6QF Edinburgh | Scotland | British | 56618420004 | |||||
| MCGAWN, David Hill | Director | 5 Ashgrove Avenue KA19 8BJ Maybole Ayrshire | British | 633240001 | ||||||
| MCGAWN, James Clement | Director | 14 Guiltreehill Alloway KA7 4XG Ayr Ayrshire | British | 68490001 | ||||||
| PARKER, Eileen Jean | Director | 7 Marina Road KA9 1QZ Prestwick Ayrshire | British | 49734650001 | ||||||
| ROBERTSON, Andrew James | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | Scotland | British | 109649810001 | |||||
| ROBERTSON, Peter | Director | 54 Fullarton Drive KA10 6LF Troon Ayrshire | United Kingdom | British | 68510001 | |||||
| RUNCIMAN, Arthur Alan | Director | 4 Marlepark Alloway KA7 4RN Ayr Ayrshire | United Kingdom | British | 115364670001 | |||||
| SCOBIE, George | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | United Kingdom | British | 99906370002 | |||||
| WOOD, Ronald Chalmers | Director | East Bridge KY1 2SR Kirkcaldy C/O Robert Hutchison Fife | England | British | 303800003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTMIN NUTRITION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrs Agriculture Limited | 06 abr 2016 | Stanwix CA3 9BA Carlisle Old Croft Cumbria England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SCOTMIN NUTRITION LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 01 nov 2000 Entregado el 08 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Warehouse at hunters hall, kelso. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 19 jul 1991 Entregado el 26 jul 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 02 abr 1987 Entregado el 09 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0