KILRON SEAFOODS LIMITED

KILRON SEAFOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKILRON SEAFOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC069667
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KILRON SEAFOODS LIMITED?

    • Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (10200) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2012 au 30 sept 2012

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Stephen Paul Leadbeater como director el 31 mar 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 3 Harbour Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9TB el 22 ene 2013

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 ene 2013

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    4 páginasMG03s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Hamish Drummond Forbes como director el 18 dic 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Paul Britton como director el 18 dic 2012

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    8 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approval of various tabled restructuring documents, directors are authorised to execute & deliver said docs, directors to avoid conflict of interest 20/09/2012
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 sept 2012

    Estado de capital el 19 sept 2012

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approval of various docs, auth of directors & sec to execute & deliver documents, directors conflict of interest 11/06/2012
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited el 15 sept 2010

    2 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 27 sept 2008

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Secretario corporativo
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02249348
    75197930001
    FORBES, Hamish Drummond
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Director
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritish66295550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Secretario
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    British2785890001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Secretario
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British72694900001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Secretario
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    WRIGHT, James Leonard
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Secretario
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British714180001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Director
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Director
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British2785880001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Director
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Director
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Director
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British72694900001
    SIM, James Ralph
    17 Strichen Road
    AB43 9SA Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Director
    17 Strichen Road
    AB43 9SA Fraserburgh
    Aberdeenshire
    British178260001
    SIM, John Buchan
    23 Strichen Court
    AB43 9SZ Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Director
    23 Strichen Court
    AB43 9SZ Fraserburgh
    Aberdeenshire
    British178270002
    THOMAS, Andrew George
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    Director
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    British40002910008
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Director
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002

    ¿Tiene KILRON SEAFOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 06 nov 2008
    Entregado el 19 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest in 2 leases of the subjects 9 & 23, reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 19 nov 2008Registro de un cargo (410)
    • 16 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 06 nov 2008
    Entregado el 19 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest in the lease of the subjects on the east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 19 nov 2008Registro de un cargo (410)
    • 16 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Debenture
    Creado el 23 oct 2008
    Entregado el 05 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 05 nov 2008Registro de un cargo (410)
    • 16 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 30 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest under the lease of ground east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 30 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest under the leases of 9 & 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Debenture
    Creado el 21 mar 2007
    Entregado el 31 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent
    Transacciones
    • 31 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 28 oct 2008
    Standard security
    Creado el 28 mar 2006
    Entregado el 31 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    The subjects comrising the tenant's interest under the lease of ground on the east side of harbour road, fraserburgh (title number ABN31395) together with the whole buildings and erections thereon.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 31 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 28 mar 2006
    Entregado el 31 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    The subjects comprising the tenant's interest under the lease of 9 and 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh (title number ABN27588) together with the whole buildings and erections thereon.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 31 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Debenture
    Creado el 16 mar 2006
    Entregado el 29 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 29 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 28 oct 2008
    Floating charge
    Creado el 12 dic 2005
    Entregado el 20 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 20 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 15 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 dic 2005
    Entregado el 28 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest under the lease of ground on east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 28 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 dic 2005
    Entregado el 28 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest under leases of 9 & 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 28 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 05 ago 2002
    Entregado el 08 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charges over assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 08 ago 2002Registro de un cargo (410)
    • 28 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 jul 2002
    Entregado el 06 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground on the east side of harbour road, fraserburgh--title number ABN31395.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 06 ago 2002Registro de un cargo (410)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 18 abr 2002
    Entregado el 26 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    9 & 23 reclaimed ground, fraserburgh.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 26 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 08 dic 1998
    Entregado el 16 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest in the minute of lease over harbour road,fraserburgh.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transacciones
    • 16 dic 1998Registro de un cargo (410)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 08 dic 1998
    Entregado el 16 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tenants interest in the lease over 23 reclaimed ground & yard at 9 reclaimed ground,fraserburgh.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transacciones
    • 16 dic 1998Registro de un cargo (410)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 25 oct 1998
    Entregado el 09 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 09 nov 1998Registro de un cargo (410)
    • 07 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 29 jun 1983
    Entregado el 07 jul 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Part of a two storey industrial development in harbour rd fraserburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 jul 1983Registro de una carga
    • 16 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 16 jul 1982
    Entregado el 03 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 ago 1982Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 11 feb 1981
    Entregado el 20 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Parish of fraserburgh harbour road, fraserburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 feb 1981Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 08 jul 1980
    Entregado el 21 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jul 1980Registro de una carga

    ¿Tiene KILRON SEAFOODS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 dic 2013Fecha de disolución
    11 ene 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Profesional
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Mark Granville Firmin
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Profesional
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0