IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC070875 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 27 jul 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Bishop como director el 01 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Muir como director el 01 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736800001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149304900001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Secretario | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Secretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Secretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Secretario corporativo | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Director | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Director | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Director | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Director | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Director | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Director | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Director | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Director | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Director | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Director | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Director | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| STUART, John Morris | Director | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Director | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Director | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Director | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Director | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 abr 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Creado el 17 ene 1991 Entregado el 21 ene 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All refunds of monies by the company by way of deposit on acquisition of motor vehicles supplied by V.A.G. and man on a consignment basis. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of offset | Creado el 05 jun 1987 Entregado el 16 jun 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and/or others | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignation in security | Creado el 20 nov 1985 Entregado el 25 nov 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All monies due to the company by V.A.G. (united kingdom) LTD dated 1/6/83. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 nov 1985 Entregado el 15 nov 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All used vehicles. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 nov 1985 Entregado el 15 nov 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of offset | Creado el 07 ago 1985 Entregado el 13 ago 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and others | |
Breve descripción All sums due to the company by the governor and company of the bank of scotland on the several accounts held by the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 01 ago 1985 Entregado el 15 ago 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 0.58 acres at the A73 lanarkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignation in security | Creado el 30 mar 1984 Entregado el 05 abr 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All monies which may from time to time be owing to the company by V.A.G. (UK) limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 dic 1982 Entregado el 13 dic 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Garage known as beacon garage, bogside and dwellinghouse known as vondercroft, lanark. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 27 jul 1981 Entregado el 11 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due but not exceeding £70,000 of principal | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 27 jul 1981 Entregado el 11 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All used motor vehicles forming or which may at any time or from time to time form part of the company's stock of used motor vehicles and proceeds of any insurance policies. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 27 jul 1981 Entregado el 11 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All monies which may from time to time be owing to the company by vag (united kingdom) limited. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 17 abr 1981 Entregado el 24 abr 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0