O.I.L. ENGINEERING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | O.I.L. ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC072717 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Dirección de la sede social | 13 Henderson Road IV1 1SN Inverness Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| O I L (ENGINEERING) LIMITED | 16 nov 1983 | 16 nov 1983 |
| OCEAN INCHCAPE (ENGINEERING) LIMITED | 03 oct 1980 | 03 oct 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Terence David Willox como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roderick James Macgregor como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Masson como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Hamilton como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Geg Capital en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr James Donald Macdonald el 01 sept 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Donald Macdonald el 01 sept 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de In-Spec House Wellheads Drive Dyce Aberdeen AB21 7GQ a 13 Henderson Road Inverness IV1 1SN el 21 ene 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACDONALD, James Donald | Secretario | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | 173184740001 | |||||||
| MACDONALD, James Donald | Director | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | Scotland | British | 155685440002 | |||||
| GOLDBLATT, Michael Lee | Secretario | 4709 Folse Drive Metairie Louisiana 70006 Usa | American | 53094660001 | ||||||
| HART, Richard | Secretario | 1 Crombie Circle AB14 0XU Peterculter Aberdeenshire | American | 56160400001 | ||||||
| LABORDE, Cliffe Floyd | Secretario | 429 Walnut Street New Orleans Louisiana 70118 Usa | American | 53094340001 | ||||||
| MAIR, Alexander Bruce | Secretario | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 | British | 92844720001 | ||||||
| RICKETTS, John Anthony | Secretario | Wellyard Nyewood GU31 5JA Petersfield Hampshire | British | 826820001 | ||||||
| WALLS, Kenneth Charles | Secretario | Silverstone 12 Jubilee Road L37 2HW Formby Merseyside | British | 24310840001 | ||||||
| WILLOX, Terence David | Secretario | 56 Dawson Drive Skene AB32 6NS Westhill Aberdeenshire | British | 123197880001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secretario corporativo | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE | Secretario corporativo | 12-16 Albyn Place AB10 1PS Aberdeen | 35622500003 | |||||||
| BARTON, Derek John | Director | Woodend The Cedars RH16 1RP Haywards Heath West Sussex | British | 767710001 | ||||||
| BUCHAN, William Jamie | Director | The Yews Knoll Road GU7 2EL Godalming Surrey | British | 44486250001 | ||||||
| BURGESS, John Graham | Director | 4 Willow Tree Way AB31 5JQ Banchory Aberdeenshire | Banchory | British | 37612260003 | |||||
| COWIE, Julie Elizabeth | Director | 5 Hartington Road AB10 6XT Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 111585570001 | |||||
| CURRENCE, Richard Morrison | Director | 541 Audubon New Orleans Louisiana 70118 Usa | American | 10304500001 | ||||||
| DICK, Stephen Wallace | Director | 5500 Durham Drive 70131 New Orleans Louisiana Usa | American | 44896530001 | ||||||
| EDWARDS, David Kendrick | Director | Kirkton House Banchory Devenick AB1 5YL Aberdeen | British | 61845880002 | ||||||
| FELTER, Peter Gjedboe, Dr | Director | Nouaihed Building BP5233/11 Beirut Sami El Sohl St Lebanon | British | 100602880002 | ||||||
| GIBBARD, Michael John | Director | Dormer Cottage 24 Weald Way CR3 6EG Caterham Surrey | British | 7528830001 | ||||||
| GILL, Bruce William | Director | 22 Norman Gray Park AB21 0ZR Blackburn Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503010001 | |||||
| GRAHAM, Patrick David | Director | The Old Vicarage Upper Chute SP11 9EN Andover Hampshire | British | 826830001 | ||||||
| HALL, Stuart | Director | Newlyn Huntly Road AB34 5HE Aboyne Aberdeenshire | British | 37727490001 | ||||||
| HAMILTON, William | Director | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen Murlingden, 8 | Scotland | British | 42252580002 | |||||
| LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan | Director | Mulberry Lodge Lodge Hill Road GU10 3RD Farnham Surrey | British | 64332640001 | ||||||
| MACGREGOR, Roderick James | Director | Delny Muirs IV18 0NP Invergordon The Cherry Trees | Scotland | British | 61748240004 | |||||
| MAIR, Alexander Bruce | Director | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 Aberdeenshire | Scotland | British | 92844720001 | |||||
| MASSON, David | Director | 18 Charleston Circle AB12 3EY Aberdeen | United Kingdom | British | 58565940001 | |||||
| MCGEEHAN, Christopher | Director | 131 Grandholm Drive Bridge Of Don AB22 8AE Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503110001 | |||||
| MCINNES, Sandy | Director | Dunstaffnage Woodside Avenue PH26 3JR Grantown On Spey Morayshire | United Kingdom | British | 52989660002 | |||||
| O'MALLEY, William Charles | Director | 4 Lakeway Court New Orleans Louisiana 70131 Usa | American | 41492720001 | ||||||
| PHILIP, Graham Martin | Director | 13 Oaklands Avenue KT10 8HX Esher Surrey | British | 2585740001 | ||||||
| ROURKE, James Lindsay | Director | Castle Airy High Street AB31 5TJ Banchory Aberdeenshire | British | 56160290002 | ||||||
| ROURKE, James Lindsay | Director | 21 St Dutchac Crescent AB31 3TG Banchory Kincardineshire | British | 56160290001 | ||||||
| SORAHAN, Peter John | Director | Bryn Hafod Wepre Lane Northop Hall CH7 6LD Mold Flintshire | British | 28674620001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geg Capital (Howe Moss) Limited | 06 abr 2016 | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene O.I.L. ENGINEERING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 08 mar 2010 Entregado el 10 mar 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 24 ene 2007 Entregado el 07 feb 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción One acre and five decimal or one tenth parts of an acre or thereby at hareness road, alterns industrial estate, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 19 ene 2007 Entregado el 01 feb 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 18 ene 2007 Entregado el 24 ene 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 24 feb 2006 Entregado el 03 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Ground at hareness road, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 17 feb 2006 Entregado el 22 feb 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 15 ago 2000 Entregado el 16 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects at hareness road, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 18 feb 1998 Entregado el 25 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0