SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC074517 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Mound EH1 1YZ Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTTISH WIDOWS FUND MANAGEMENT LIMITED | 14 abr 1981 | 14 abr 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mrs Dena Jane Brumpton como director el 02 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Scott Wheway como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Mary Helen Trussell como director el 07 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Joanna Kate Harris como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Deborah Lee Davis como director el 18 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Christopher John George Moulder el 02 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Matthew Hilmar Cuhls el 02 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Deborah Lee Davis el 02 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Gayle Elaine Schumacher el 02 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 69 Morrison Street Edinburgh EH3 8BW United Kingdom a The Mound Edinburgh EH1 1YZ el 02 dic 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mrs Caroline Anne Riddy como secretario el 13 sept 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Jesujuwonlo Williams como secretario el 12 sept 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Paul Gerard Mcnamara como director el 02 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony Jonathan Reizenstein como director el 30 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Jesujuwonlo Williams como secretario el 29 mar 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Joanne Margaret Jolly como secretario el 28 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mrs Kirstine Ann Cooper como director el 01 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Joanna Kate Harris el 16 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Ronald Downie como director el 15 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Shingirai Thaddeus Nyahasha como director el 15 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDDY, Caroline Anne | Secretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 327329780001 | |||||||
| BARUA, Chirantan | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 309933170001 | |||||
| BRUMPTON, Dena Jane | Director | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 238482170001 | |||||
| CHALMERS, William Leon David | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 261222830001 | |||||
| COOPER, Kirstine Ann | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 320134320001 | |||||
| CUHLS, Matthew Hilmar | Director | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 317975950001 | |||||
| MCNAMARA, Paul Gerard | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 156860390001 | |||||
| MOULDER, Christopher John George | Director | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 233902290008 | |||||
| NYAHASHA, Shingirai Thaddeus | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 318476210001 | |||||
| SCHUMACHER, Gayle Elaine | Director | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 70147240004 | |||||
| TRUSSELL, Mary Helen | Director | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 338054460001 | |||||
| CLARKE, David | Secretario | Morrison Street EH3 8YF Edinburgh 69 United Kingdom | 194630990001 | |||||||
| HANKIN, Christina Ann | Secretario | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | 250712690001 | |||||||
| HOOTON, Tamsin | Secretario | Morrison Street EH3 8YF Edinburgh 69 United Kingdom | 190089480001 | |||||||
| HOUSTON, Thomas Black | Secretario | Ferndale 70 Garvock Hill KY12 7UU Dunfermline Fife | British | 6871150001 | ||||||
| JOLLY, Joanne Margaret | Secretario | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | 266154210001 | |||||||
| MCFARLANE, Jennifer Helen | Secretario | 13 Seaforth Drive EH4 2BX Edinburgh Lothian | British | 58275060001 | ||||||
| NICHOLLS, Tracey Caroline | Secretario | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | 191130680001 | |||||||
| NICHOLLS, Tracey Caroline | Secretario | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat Lloyds Banking Gro United Kingdom | British | 95560620001 | ||||||
| PASSMORE, Nigel Howard | Secretario | 5/1 Sienna Gardens EH9 1PG Edinburgh | British | 60741210001 | ||||||
| RAYMOND, Hugh William | Secretario | Staddlestones Belwood Road Milton Bridge EH26 0NL Penicuik Midlothian | British | 27170500001 | ||||||
| SHAH, Farhat | Secretario | Flat 2/2, 8 Grantley Gardens Shawlands G41 3QA Glasgow | British | 101169780001 | ||||||
| TALBOT, Alison Janet, Ms. | Secretario | 12 Kings Park EH32 0QL Longniddry East Lothian Scotland | British | 57177110002 | ||||||
| TALBOT, Alison Janet | Secretario | 51 Gateside Avenue EH41 3SE Haddington East Lothian | British | 57177110001 | ||||||
| WILLIAMS, Jesujuwonlo | Secretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 321177220001 | |||||||
| AIKEN, Donald | Director | 35 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | 41417250001 | ||||||
| ANGUS, Derek | Director | 6 Balruddery Meadows Invergowrie DD2 5LJ Dundee Angus | British | 68067940001 | ||||||
| ARCHIBALD, Thomas Douglas Raeburn | Director | Lothian House 124/12 Lothian Road EH3 9BG Edinburgh | British | 49621040001 | ||||||
| BLACK, Colin Hyndmarsh | Director | 15 Tudor Close Fairmile Park Road KT11 2PH Cobham Surrey | British | 482150001 | ||||||
| BLACK, James Masson | Director | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | United Kingdom | British | 172334880001 | |||||
| BLANCE, Andrea Margaret | Director | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 334529130001 | |||||
| BOND, Jonathon Roderick Alan | Director | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8BW Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 183950240001 | |||||
| BOYD, James Edward | Director | Dunard Station Road G84 8LW Rhu Dunbartonshire | British | 34645330001 | ||||||
| BRIGGS, Andrew David | Director | 48 Holland Park Avenue W11 3QY London | United Kingdom | British | 75581620003 | |||||
| CAMERON, Angus Kenneth | Director | 33 Newbattle Gardens EH22 3DR Eskbank Midlothian | British | 74975430004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES (NOMINEES) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Widows Administration Services Limited | 27 mar 2018 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Scottish Widows Financial Services Holdings | 06 abr 2016 | Morrison Street EH3 8YF Edinburgh 69 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0