HB (SC) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HB (SC) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC074732 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HB (SC) LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra HB (SC) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Blairton House Old Aberdeen Road Balmedie AB23 8SH Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HB (SC) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REDROW HOMES (SCOTLAND) LIMITED | 22 feb 2002 | 22 feb 2002 |
| TAY HOMES (SCOTLAND) LIMITED | 07 may 1981 | 07 may 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HB (SC) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HB (SC) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HB (SC) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Ian Scott como director el 13 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Ian Scott como director el 21 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Helen Davies como director el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Barratt Corporate Secretarial Services Limited como secretario el 01 ago 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Bethany Ford como secretario el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Timothy Huw Stone como director el 27 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Neil Robinson como director el 27 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE United Kingdom a Blairton House Old Aberdeen Road Balmedie Aberdeen AB23 8SH el 01 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 1 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Neil Robinson como director el 31 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Bethany Ford como secretario el 30 nov 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como director el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como secretario el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE United Kingdom a C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Kenneth Meldrum PO Box Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG a Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Helen Davies como director el 22 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Graham Anthony Cope como director el 22 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HB (SC) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom |
| 160289260001 | ||||||||||
| STONE, Timothy Huw | Director | St David's Park CH5 3RX Flintshire Redrow House United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 297709310001 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Secretario | Cadworks 9th Floor G2 6SE 41 West Campbell Street C/O Tlt Llp Glasgow United Kingdom | British | 85842880003 | ||||||||||
| EVANS, Stephen Geoffrey | Secretario | The Orchard 58 Huddersfield Road Skelmanthorpe HD8 9AS Huddersfield West Yorkshire | British | 3621900001 | ||||||||||
| FORD, Bethany | Secretario | St. David's Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire Wales | 316534400001 | |||||||||||
| WALKER, Rhiannon Ellis | Secretario | Gatesheath Hall Gatesheath Tattenhall CH3 9AH Chester Cheshire | British | 86070003 | ||||||||||
| AITON, William Hardie | Director | 4-117 Ingram Street G1 1DJ Glasgow Lanarkshire | British | 1165600001 | ||||||||||
| ANDERSON, Anne Janet | Director | 195 The Moorings St Davids Harbour KY11 9GX Dalgetty Bay Fife | British | 89327260002 | ||||||||||
| ANDERSON, William Muir | Director | 7 Campbell Drive Bearsden G61 4NF Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1028880002 | |||||||||
| ARNOLD, David Llewelyn | Director | Garden Cottage Horton Green SY14 7EZ Tilston Cheshire | United Kingdom | British | 181213200001 | |||||||||
| BAKER, David Andrew | Director | 9 Nursery Grove PA13 4HW Kilmacolm Renfrewshire | British | 44963630001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Henry | Director | 28 Riverside Road West Moors BH22 0LQ Ferndown Dorset | United Kingdom | British | 58990140003 | |||||||||
| BRAND, William John | Director | c/o C/O Kenneth Meldrum West George Street Tlt Llp G2 2HG Glasgow 140 Scotland | England | British | 5202410003 | |||||||||
| BURY, Michael | Director | Redrow House 3 Central Park Avenue FK5 4RX Larbert Falkirk | United Kingdom | British | 87734280001 | |||||||||
| CAMPBELL KELLY, David John | Director | Bridgemere House Yew Tree Close LE8 6BU Willoughby Waterleys Leicestershire | British | 40876330001 | ||||||||||
| CLARKE, Anthony Thomas | Director | 7 Nursery Grove PA13 4HW Kilmacolm Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 145620001 | |||||||||
| CLEARY, Michael Peter | Director | 95 Northenden Road M33 2ED Sale Cheshire | United Kingdom | British | 119436580002 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Director | Cadworks 9th Floor G2 6SE 41 West Campbell Street C/O Tlt Llp Glasgow United Kingdom | England | British | 289766770001 | |||||||||
| CROMBIE, Colin | Director | 3 Crinan Place KY11 8FR Dunfermline Fife | British | 111176290001 | ||||||||||
| DAVIES, Helen | Director | Old Aberdeen Road Balmedie AB23 8SH Aberdeen Blairton House Scotland | United Kingdom | British | 83638070001 | |||||||||
| DICKSON, Ian Macdonald | Director | 11 Antonine Road G68 0FE Dullatur Lanarkshire | Scotland | British | 180862450001 | |||||||||
| DUNLOP, Graeme Tyrell | Director | Redrow House 3 Central Park Avenue FK5 4RX Larbert Falkirk | Scotland | British | 150360810001 | |||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | 31 Rean Meadow Tattenhall CH3 9PU Chester Cheshire | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||||||
| GLOVER, George Edward | Director | The Knowe 42 Auchinleck Road KA18 1AE Cumnock Ayrshire | Scotland | British | 33791990001 | |||||||||
| HARKINS, James | Director | 46 Dunvegan Drive Bishopbriggs G64 3LD Glasgow | British | 77738360001 | ||||||||||
| HARVEY, Barry Kendrick | Director | Hollybank Pepper Street Appleton Thorn WA4 4SB Warrington Cheshire | England | British | 46807640004 | |||||||||
| LEWIS, Alun Watkin | Director | Pennant 1 Ffordd Dolgoed CH7 1PE Yr Wyddgrug Sir Y Fflint | Wales | British | 37977020001 | |||||||||
| LLOYD, Steven Paul | Director | 10 Woodvale Avenue ML6 8RW Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | 59661010001 | |||||||||
| MACFARLANE, Douglas Leckie | Director | The Bungalow 6 Barrmill Road KA15 1EU Beith Ayrshire | British | 632850001 | ||||||||||
| MAUNDERS, John Ware | Director | Tay House 55 Call Lane LS1 7BT Leeds West Yorkshire | British | 64311440001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | c/o C/O Kenneth Meldrum West George Street Tlt Llp G2 2HG Glasgow 140 Scotland | Scotland | British | 147233120001 | |||||||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | Cupar Road Lundin Links KY8 6DQ Leven The Stables Fife Scotland | Scotland | British | 147233120001 | |||||||||
| MCFARLAND, William | Director | Langsted 7b Corsehill Drive KA23 9HU West Kilbride | Scotland | British | 83816750001 | |||||||||
| MCGINTY, James Andrew | Director | Redrow House 3 Central Park Avenue FK5 4RX Larbert Falkirk | United Kingdom | British | 64908100003 | |||||||||
| MCLACHLAN, Colin Michael | Director | 85 Woodfield Avenue EH13 0QR Colinton Edinburgh | British | 68856430002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HB (SC) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb (Cpts) Limited | 06 abr 2016 | St. Davids Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0