HB (SC) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHB (SC) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC074732
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HB (SC) LIMITED?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra HB (SC) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Blairton House Old Aberdeen Road
    Balmedie
    AB23 8SH Aberdeen
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HB (SC) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REDROW HOMES (SCOTLAND) LIMITED22 feb 200222 feb 2002
    TAY HOMES (SCOTLAND) LIMITED07 may 198107 may 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HB (SC) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2025
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HB (SC) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta10 dic 2026
    Próxima declaración de confirmación vence24 dic 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta10 dic 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HB (SC) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Ian Scott como director el 13 nov 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Ian Scott como director el 21 ago 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Helen Davies como director el 31 jul 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Barratt Corporate Secretarial Services Limited como secretario el 01 ago 2025

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Bethany Ford como secretario el 31 jul 2025

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Timothy Huw Stone como director el 27 jun 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Robinson como director el 27 jun 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE United Kingdom a Blairton House Old Aberdeen Road Balmedie Aberdeen AB23 8SH el 01 nov 2024

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024

    1 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Robinson como director el 31 dic 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Bethany Ford como secretario el 30 nov 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como director el 30 nov 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como secretario el 30 nov 2023

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023

    1 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE United Kingdom a C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Kenneth Meldrum PO Box Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG a Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022

    1 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Helen Davies como director el 22 nov 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Graham Anthony Cope como director el 22 nov 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de HB (SC) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro05698395
    160289260001
    STONE, Timothy Huw
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Redrow House
    United Kingdom
    United Kingdom
    Director
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Redrow House
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish297709310001
    COPE, Graham Anthony
    Cadworks
    9th Floor
    G2 6SE 41 West Campbell Street
    C/O Tlt Llp
    Glasgow
    United Kingdom
    Secretario
    Cadworks
    9th Floor
    G2 6SE 41 West Campbell Street
    C/O Tlt Llp
    Glasgow
    United Kingdom
    British85842880003
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    British3621900001
    FORD, Bethany
    St. David's Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    Wales
    Secretario
    St. David's Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    Wales
    316534400001
    WALKER, Rhiannon Ellis
    Gatesheath Hall
    Gatesheath Tattenhall
    CH3 9AH Chester
    Cheshire
    Secretario
    Gatesheath Hall
    Gatesheath Tattenhall
    CH3 9AH Chester
    Cheshire
    British86070003
    AITON, William Hardie
    4-117 Ingram Street
    G1 1DJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    4-117 Ingram Street
    G1 1DJ Glasgow
    Lanarkshire
    British1165600001
    ANDERSON, Anne Janet
    195 The Moorings
    St Davids Harbour
    KY11 9GX Dalgetty Bay
    Fife
    Director
    195 The Moorings
    St Davids Harbour
    KY11 9GX Dalgetty Bay
    Fife
    British89327260002
    ANDERSON, William Muir
    7 Campbell Drive
    Bearsden
    G61 4NF Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    7 Campbell Drive
    Bearsden
    G61 4NF Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish1028880002
    ARNOLD, David Llewelyn
    Garden Cottage
    Horton Green
    SY14 7EZ Tilston
    Cheshire
    Director
    Garden Cottage
    Horton Green
    SY14 7EZ Tilston
    Cheshire
    United KingdomBritish181213200001
    BAKER, David Andrew
    9 Nursery Grove
    PA13 4HW Kilmacolm
    Renfrewshire
    Director
    9 Nursery Grove
    PA13 4HW Kilmacolm
    Renfrewshire
    British44963630001
    BANNISTER, William Henry
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Director
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritish58990140003
    BRAND, William John
    c/o C/O Kenneth Meldrum
    West George Street
    Tlt Llp
    G2 2HG Glasgow
    140
    Scotland
    Director
    c/o C/O Kenneth Meldrum
    West George Street
    Tlt Llp
    G2 2HG Glasgow
    140
    Scotland
    EnglandBritish5202410003
    BURY, Michael
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    Director
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    United KingdomBritish87734280001
    CAMPBELL KELLY, David John
    Bridgemere House
    Yew Tree Close
    LE8 6BU Willoughby Waterleys
    Leicestershire
    Director
    Bridgemere House
    Yew Tree Close
    LE8 6BU Willoughby Waterleys
    Leicestershire
    British40876330001
    CLARKE, Anthony Thomas
    7 Nursery Grove
    PA13 4HW Kilmacolm
    Renfrewshire
    Scotland
    Director
    7 Nursery Grove
    PA13 4HW Kilmacolm
    Renfrewshire
    Scotland
    United KingdomBritish145620001
    CLEARY, Michael Peter
    95 Northenden Road
    M33 2ED Sale
    Cheshire
    Director
    95 Northenden Road
    M33 2ED Sale
    Cheshire
    United KingdomBritish119436580002
    COPE, Graham Anthony
    Cadworks
    9th Floor
    G2 6SE 41 West Campbell Street
    C/O Tlt Llp
    Glasgow
    United Kingdom
    Director
    Cadworks
    9th Floor
    G2 6SE 41 West Campbell Street
    C/O Tlt Llp
    Glasgow
    United Kingdom
    EnglandBritish289766770001
    CROMBIE, Colin
    3 Crinan Place
    KY11 8FR Dunfermline
    Fife
    Director
    3 Crinan Place
    KY11 8FR Dunfermline
    Fife
    British111176290001
    DAVIES, Helen
    Old Aberdeen Road
    Balmedie
    AB23 8SH Aberdeen
    Blairton House
    Scotland
    Director
    Old Aberdeen Road
    Balmedie
    AB23 8SH Aberdeen
    Blairton House
    Scotland
    United KingdomBritish83638070001
    DICKSON, Ian Macdonald
    11 Antonine Road
    G68 0FE Dullatur
    Lanarkshire
    Director
    11 Antonine Road
    G68 0FE Dullatur
    Lanarkshire
    ScotlandBritish180862450001
    DUNLOP, Graeme Tyrell
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    Director
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    ScotlandBritish150360810001
    FITZSIMMONS, Neil
    31 Rean Meadow
    Tattenhall
    CH3 9PU Chester
    Cheshire
    Director
    31 Rean Meadow
    Tattenhall
    CH3 9PU Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish69006050002
    GLOVER, George Edward
    The Knowe
    42 Auchinleck Road
    KA18 1AE Cumnock
    Ayrshire
    Director
    The Knowe
    42 Auchinleck Road
    KA18 1AE Cumnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish33791990001
    HARKINS, James
    46 Dunvegan Drive
    Bishopbriggs
    G64 3LD Glasgow
    Director
    46 Dunvegan Drive
    Bishopbriggs
    G64 3LD Glasgow
    British77738360001
    HARVEY, Barry Kendrick
    Hollybank Pepper Street
    Appleton Thorn
    WA4 4SB Warrington
    Cheshire
    Director
    Hollybank Pepper Street
    Appleton Thorn
    WA4 4SB Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish46807640004
    LEWIS, Alun Watkin
    Pennant
    1 Ffordd Dolgoed
    CH7 1PE Yr Wyddgrug
    Sir Y Fflint
    Director
    Pennant
    1 Ffordd Dolgoed
    CH7 1PE Yr Wyddgrug
    Sir Y Fflint
    WalesBritish37977020001
    LLOYD, Steven Paul
    10 Woodvale Avenue
    ML6 8RW Airdrie
    Lanarkshire
    Director
    10 Woodvale Avenue
    ML6 8RW Airdrie
    Lanarkshire
    ScotlandBritish59661010001
    MACFARLANE, Douglas Leckie
    The Bungalow 6 Barrmill Road
    KA15 1EU Beith
    Ayrshire
    Director
    The Bungalow 6 Barrmill Road
    KA15 1EU Beith
    Ayrshire
    British632850001
    MAUNDERS, John Ware
    Tay House
    55 Call Lane
    LS1 7BT Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Tay House
    55 Call Lane
    LS1 7BT Leeds
    West Yorkshire
    British64311440001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    c/o C/O Kenneth Meldrum
    West George Street
    Tlt Llp
    G2 2HG Glasgow
    140
    Scotland
    Director
    c/o C/O Kenneth Meldrum
    West George Street
    Tlt Llp
    G2 2HG Glasgow
    140
    Scotland
    ScotlandBritish147233120001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    Cupar Road
    Lundin Links
    KY8 6DQ Leven
    The Stables
    Fife
    Scotland
    Director
    Cupar Road
    Lundin Links
    KY8 6DQ Leven
    The Stables
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish147233120001
    MCFARLAND, William
    Langsted
    7b Corsehill Drive
    KA23 9HU West Kilbride
    Director
    Langsted
    7b Corsehill Drive
    KA23 9HU West Kilbride
    ScotlandBritish83816750001
    MCGINTY, James Andrew
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    Director
    Redrow House
    3 Central Park Avenue
    FK5 4RX Larbert
    Falkirk
    United KingdomBritish64908100003
    MCLACHLAN, Colin Michael
    85 Woodfield Avenue
    EH13 0QR Colinton
    Edinburgh
    Director
    85 Woodfield Avenue
    EH13 0QR Colinton
    Edinburgh
    British68856430002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HB (SC) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hb (Cpts) Limited
    St. Davids Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    St. Davids Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro1079513
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0