CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC076761 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Peter David Malcolm el 13 nov 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Nombramiento de Ms Laura Elisabeth Tee como director el 13 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Davinia Elaine Smith como director el 13 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Segunda presentación para la notificación de Cg Cutlers Gardens (Uk) No 2 Limited como persona con control significativo | 6 páginas | RP04PSC02 | ||||||
Notification de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||||||
Cessation de Cg Cutlers Gardens Limited Partnership en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Notification de Cg Cutlers Gardens Limited Partnership en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025 | 3 páginas | PSC02 | ||||||
| ||||||||
Cessation de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024 | 18 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 19 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del director Mr Jonathan Kudzanai Muteera el 13 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Notification de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||
Cessation de Mount Street Mortgage Servicing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr Peter David Malcolm como director el 04 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cambio de datos del secretario Apex Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023 | 1 páginas | CH04 | ||||||
Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023 | 1 páginas | CH04 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Jonathan Kudzanai Muteera el 07 nov 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Kudzanai Muteera como director el 07 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Ivee Rachel Briones Gill como director el 07 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Registro de la carga SC0767610014, creada el 16 ago 2023 | 69 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga SC0767610013, creada el 16 ago 2023 | 15 páginas | MR01 | ||||||
Cancelación total de la carga SC0767610008 | 1 páginas | MR04 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor, 125 England |
| 175738460002 | ||||||||||
| MALCOLM, Peter David | Director | London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor, 125 England | England | British | 310941860002 | |||||||||
| MUTEERA, Jonathan Kudzanai | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 314900570002 | |||||||||
| TEE, Laura Elisabeth | Director | Aldersgate Street EC1A 4HY London 4th Floor, 140 England | England | New Zealander | 317368870001 | |||||||||
| DIENST, Gary John | Secretario | 67 Lambert Ridge Cross River New York 10518 Usa | Us | 78635620001 | ||||||||||
| FOTHERINGHAM, David Drysdale | Secretario | 2 Southbank Easter Park Drive EH4 6SG Edinburgh Midlothian | British | 105786920001 | ||||||||||
| FOX, Patrick Kenny | Secretario | 5709 Moss Creek Crt Dallas Texas 75252 Usa | American | 108149730001 | ||||||||||
| GRAY, Archibald James Angus Macuish | Secretario | Boswall House 19 Boswall Road EH5 3RR Edinburgh Midlothian | British | 1079190001 | ||||||||||
| JONES, Tracy Alexandra | Secretario | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | British | 171520820002 | ||||||||||
| RICHEY, Kent | Secretario | 801 West End Avenue Apt 10a YO23 7DE New York New York 10025 Usa | American | 63321970001 | ||||||||||
| SOMERVILLE, Peter Walter | Secretario | 46 New Street EH21 6JN Musselburgh Midlothian | British | 46508890001 | ||||||||||
| TRUONG, Anh | Secretario | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | 187135790001 | |||||||||||
| BELL, Alexander Scott | Director | 28 East Barnton Avenue EH4 6AQ Edinburgh Midlothian | British | 802090001 | ||||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BINGHAM, Jason Christopher | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | England | British | 225343320001 | |||||||||
| CROMBIE, Alexander Maxwell, Sir | Director | Greenore Ancrum Road EH22 3AJ Dalkeith | British | 144639880001 | ||||||||||
| DAVIES, Simon David Austin | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | United Kingdom | British | 197508390001 | |||||||||
| DIENST, Gary John | Director | 67 Lambert Ridge Cross River New York 10518 Usa | Us | 78635620001 | ||||||||||
| FOX, Patrick Kenny | Director | Melville Crescent EH3 7JA Edinburgh 7 Scotland | Usa | American | 108149730001 | |||||||||
| GILL, Ivee Rachel Gervasio | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor England | England | British | 300699830001 | |||||||||
| HARTMAN, Gregory J | Director | Melville Crescent EH3 7JA Edinburgh 7 Scotland | Usa | American | 152466160001 | |||||||||
| KATAKY, Gemma Nandita | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | England | British | 208442910001 | |||||||||
| LOCK, James Robert | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | United Kingdom | British | 195412690001 | |||||||||
| MCKIE, Gordon Robert | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | England | British | 155757550001 | |||||||||
| O'CONNOR, Jeremiah William | Director | 293 Pondfield Road Ny 10708 Bronxville Usa | Usa | American | 62456750001 | |||||||||
| PAUL, Jonathan Herbert | Director | 192 Meadowbrook Road Weston Ma 02493 Usa | Usa | American | 117219520001 | |||||||||
| PEGLER, Michael John | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 113065790002 | |||||||||
| QUINN, Thomas Edward | Director | 851 Bellis Parkway FOREIGN Oradell New Jersey America | United States | American | 78635590001 | |||||||||
| RUDD, Guy Lukin | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 139522390001 | |||||||||
| SIMPSON, David Macdonald | Director | 6 Cumlodden Avenue EH12 6DR Edinburgh Midlothian | British | 452090001 | ||||||||||
| SMITH, Davinia Elaine | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor England | United Kingdom | Irish | 253196500001 | |||||||||
| STRETTON, James | Director | 15 Letham Mains EH41 4NW Haddington East Lothian | Britain | British | 451260001 | |||||||||
| VASILEV, Panayot Kostadinov | Director | Lothian Road EH3 9WJ Edinburgh 50 Lothian Road Scotland | United Kingdom | Bulgarian | 206224490001 | |||||||||
| VENTER, Ian Stephen | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | England | British | 233812840001 | |||||||||
| WARNES, Christopher Michael | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | England | British | 222731770001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cg Cutlers Gardens (Uk) No. 2 Limited | 30 sept 2025 | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London 4th Floor United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Situs Asset Management Limited | 30 sept 2025 | 25 North Colonnade E14 5HZ London 10th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Situs Asset Management Limited | 16 ago 2023 | North Colonnade E14 5HZ London 10th Floor England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mount Street Mortgage Servicing Limited | 13 abr 2018 | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Hatfield Phillips Agency Services Limited | 17 may 2016 | Canada Square E14 5LB London 25 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0