CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED

CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC076761
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta07 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence21 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta07 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Mr Peter David Malcolm el 13 nov 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Laura Elisabeth Tee como director el 13 feb 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Davinia Elaine Smith como director el 13 feb 2026

    1 páginasTM01

    Segunda presentación para la notificación de Cg Cutlers Gardens (Uk) No 2 Limited como persona con control significativo

    6 páginasRP04PSC02

    Notification de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025

    2 páginasPSC02

    Cessation de Cg Cutlers Gardens Limited Partnership en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025

    1 páginasPSC07

    Notification de Cg Cutlers Gardens Limited Partnership en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025

    3 páginasPSC02
    Anotaciones
    FechaAnotación
    26 nov 2025Clarification A second filed PSC02 was registered on 26/11/2025

    Cessation de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2025

    1 páginasPSC07

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    19 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Jonathan Kudzanai Muteera el 13 sept 2024

    2 páginasCH01

    Notification de Situs Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2023

    2 páginasPSC02

    Cessation de Mount Street Mortgage Servicing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2023

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Peter David Malcolm como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Apex Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Mr Jonathan Kudzanai Muteera el 07 nov 2023

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Jonathan Kudzanai Muteera como director el 07 nov 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ivee Rachel Briones Gill como director el 07 nov 2023

    1 páginasTM01

    Registro de la carga SC0767610014, creada el 16 ago 2023

    69 páginasMR01

    Registro de la carga SC0767610013, creada el 16 ago 2023

    15 páginasMR01

    Cancelación total de la carga SC0767610008

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    APEX GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Secretario corporativo
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro08334728
    175738460002
    MALCOLM, Peter David
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    EnglandBritish310941860002
    MUTEERA, Jonathan Kudzanai
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    United Kingdom
    Director
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish314900570002
    TEE, Laura Elisabeth
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor, 140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor, 140
    England
    EnglandNew Zealander317368870001
    DIENST, Gary John
    67 Lambert Ridge
    Cross River
    New York 10518
    Usa
    Secretario
    67 Lambert Ridge
    Cross River
    New York 10518
    Usa
    Us78635620001
    FOTHERINGHAM, David Drysdale
    2 Southbank
    Easter Park Drive
    EH4 6SG Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    2 Southbank
    Easter Park Drive
    EH4 6SG Edinburgh
    Midlothian
    British105786920001
    FOX, Patrick Kenny
    5709 Moss Creek Crt
    Dallas
    Texas 75252
    Usa
    Secretario
    5709 Moss Creek Crt
    Dallas
    Texas 75252
    Usa
    American108149730001
    GRAY, Archibald James Angus Macuish
    Boswall House 19 Boswall Road
    EH5 3RR Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    Boswall House 19 Boswall Road
    EH5 3RR Edinburgh
    Midlothian
    British1079190001
    JONES, Tracy Alexandra
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Secretario
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    British171520820002
    RICHEY, Kent
    801 West End Avenue Apt 10a
    YO23 7DE New York
    New York 10025
    Usa
    Secretario
    801 West End Avenue Apt 10a
    YO23 7DE New York
    New York 10025
    Usa
    American63321970001
    SOMERVILLE, Peter Walter
    46 New Street
    EH21 6JN Musselburgh
    Midlothian
    Secretario
    46 New Street
    EH21 6JN Musselburgh
    Midlothian
    British46508890001
    TRUONG, Anh
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Secretario
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    187135790001
    BELL, Alexander Scott
    28 East Barnton Avenue
    EH4 6AQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    28 East Barnton Avenue
    EH4 6AQ Edinburgh
    Midlothian
    British802090001
    BIDEL, Coral Suzanne
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish179297460002
    BINGHAM, Jason Christopher
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish225343320001
    CROMBIE, Alexander Maxwell, Sir
    Greenore Ancrum Road
    EH22 3AJ Dalkeith
    Director
    Greenore Ancrum Road
    EH22 3AJ Dalkeith
    British144639880001
    DAVIES, Simon David Austin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish197508390001
    DIENST, Gary John
    67 Lambert Ridge
    Cross River
    New York 10518
    Usa
    Director
    67 Lambert Ridge
    Cross River
    New York 10518
    Usa
    Us78635620001
    FOX, Patrick Kenny
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    Director
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    UsaAmerican108149730001
    GILL, Ivee Rachel Gervasio
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Director
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    EnglandBritish300699830001
    HARTMAN, Gregory J
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    Director
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    UsaAmerican152466160001
    KATAKY, Gemma Nandita
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish208442910001
    LOCK, James Robert
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish195412690001
    MCKIE, Gordon Robert
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandBritish155757550001
    O'CONNOR, Jeremiah William
    293 Pondfield Road
    Ny 10708
    Bronxville
    Usa
    Director
    293 Pondfield Road
    Ny 10708
    Bronxville
    Usa
    UsaAmerican62456750001
    PAUL, Jonathan Herbert
    192 Meadowbrook Road
    Weston
    Ma 02493
    Usa
    Director
    192 Meadowbrook Road
    Weston
    Ma 02493
    Usa
    UsaAmerican117219520001
    PEGLER, Michael John
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomBritish113065790002
    QUINN, Thomas Edward
    851 Bellis Parkway
    FOREIGN Oradell
    New Jersey
    America
    Director
    851 Bellis Parkway
    FOREIGN Oradell
    New Jersey
    America
    United StatesAmerican78635590001
    RUDD, Guy Lukin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomBritish139522390001
    SIMPSON, David Macdonald
    6 Cumlodden Avenue
    EH12 6DR Edinburgh
    Midlothian
    Director
    6 Cumlodden Avenue
    EH12 6DR Edinburgh
    Midlothian
    British452090001
    SMITH, Davinia Elaine
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Director
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    United KingdomIrish253196500001
    STRETTON, James
    15 Letham Mains
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    Director
    15 Letham Mains
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    BritainBritish451260001
    VASILEV, Panayot Kostadinov
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    United KingdomBulgarian206224490001
    VENTER, Ian Stephen
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish233812840001
    WARNES, Christopher Michael
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish222731770001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CUTLERS GARDENS ESTATES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    United Kingdom
    30 sept 2025
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    United Kingdom
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04131250
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    25 North Colonnade
    E14 5HZ London
    10th Floor
    England
    30 sept 2025
    25 North Colonnade
    E14 5HZ London
    10th Floor
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06738409
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    North Colonnade
    E14 5HZ London
    10th Floor
    England
    16 ago 2023
    North Colonnade
    E14 5HZ London
    10th Floor
    England
    Forma jurídicaPrivate Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalThe Companies Act Of 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06738409
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    13 abr 2018
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Número de registro03411668
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Canada Square
    E14 5LB London
    25
    England
    17 may 2016
    Canada Square
    E14 5LB London
    25
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06892862
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0