BLUE CHIP TRAVEL LIMITED

BLUE CHIP TRAVEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLUE CHIP TRAVEL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC077103
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Peter Eric Buckley como director el 27 sept 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Eric Buckley como secretario el 27 sept 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Nigel John Arthur como secretario el 27 sept 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Nigel John Arthur como director el 27 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 feb 2016

    Estado de capital el 17 feb 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 feb 2015

    Estado de capital el 09 feb 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Christopher James Gadsby como director el 19 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kevan Ronald Witts como director el 03 dic 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Nigel John Arthur como secretario el 03 dic 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Kevan Witts como secretario el 03 dic 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Nigel John Arthur como director el 03 dic 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Gadsby como secretario el 11 sept 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Christopher Gadsby como secretario el 11 sept 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Kevan Witts como secretario el 11 sept 2014

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Kevan Witts como director el 11 sept 2014

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2DB el 22 jul 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 feb 2014

    Estado de capital el 07 feb 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BUCKLEY, Peter Eric
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Secretario
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    215237130001
    BUCKLEY, Peter Eric
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    EnglandBritish14052080003
    SMITH, Ian
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    United KingdomBritish5734800003
    ARTHUR, Nigel John
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Secretario
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    193406400001
    GADSBY, Christopher
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Secretario
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    162103310001
    GREEN, Patricia Madeleine
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    Secretario
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    British104931180001
    HARDMAN, John Benjamin
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secretario
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131024350001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Secretario
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    RAMSAY, Fiona Ann
    The Courtyard
    Main Street
    KY9 1LG Kilconquhar
    Fife
    Secretario
    The Courtyard
    Main Street
    KY9 1LG Kilconquhar
    Fife
    British40987540003
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    British125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Secretario
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    British59274640002
    WITTS, Kevan
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Secretario
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    190944710001
    ARTHUR, Nigel John
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    EnglandEnglish175689210001
    BROWN, David John
    49 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    49 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandScottish69967190001
    BURTON, William John
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Director
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    EnglandBritish64885440001
    COE, Albert Henry
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    Director
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    United KingdomBritish3977310002
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Director
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    GADSBY, Christopher James
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    EnglandBritish118396090002
    GREEN, Patricia Madeleine
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    Director
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    ScotlandBritish104931180001
    GREEN, Richard John
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    Director
    The Old Farmhouse
    Easter Balgedie
    KY13 9HQ Kinross
    ScotlandBritish104931190001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Director
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    RAMSAY, Fiona Ann
    The Courtyard
    Main Street
    KY9 1LG Kilconquhar
    Fife
    Director
    The Courtyard
    Main Street
    KY9 1LG Kilconquhar
    Fife
    ScotlandBritish40987540003
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish125431690001
    SPRIGGS, Pauline Ann
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    Director
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    United KingdomBritish47259460001
    THOMAS, Hywel David
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Director
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    EnglandBritish59274640002
    WATTS, Mark Bingham Titus
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    Director
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    United KingdomBritish43948350004
    WITTS, Kevan Ronald
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    20
    Scotland
    EnglandBritish83156160001

    ¿Tiene BLUE CHIP TRAVEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 14 jul 1993
    Entregado el 21 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    37 hill street north lane, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 jul 1993Registro de un cargo (410)
    • 16 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 ene 1991
    Entregado el 30 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    15 hill street edinburgh.
    Personas con derecho
    • Noble Grossart Limited
    Transacciones
    • 30 ene 1991Registro de una carga
    • 17 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 feb 1989
    Entregado el 15 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Office premises 15 hill street, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Noble Grossart Limited
    Transacciones
    • 15 feb 1989Registro de una carga
    • 17 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 31 ene 1989
    Entregado el 07 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Noble Grossart Limited
    Transacciones
    • 07 feb 1989Registro de una carga
    • 21 jul 1993Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 11 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0