BLUE CHIP TRAVEL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BLUE CHIP TRAVEL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC077103 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Eric Buckley como director el 27 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Eric Buckley como secretario el 27 sept 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel John Arthur como secretario el 27 sept 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel John Arthur como director el 27 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher James Gadsby como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevan Ronald Witts como director el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nigel John Arthur como secretario el 03 dic 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevan Witts como secretario el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nigel John Arthur como director el 03 dic 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Gadsby como secretario el 11 sept 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Gadsby como secretario el 11 sept 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevan Witts como secretario el 11 sept 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevan Witts como director el 11 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2DB el 22 jul 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 feb 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2012 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 feb 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLUE CHIP TRAVEL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKLEY, Peter Eric | Secretario | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 | 215237130001 | |||||||
| BUCKLEY, Peter Eric | Director | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 | England | British | 14052080003 | |||||
| SMITH, Ian | Director | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | United Kingdom | British | 5734800003 | |||||
| ARTHUR, Nigel John | Secretario | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | 193406400001 | |||||||
| GADSBY, Christopher | Secretario | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | 162103310001 | |||||||
| GREEN, Patricia Madeleine | Secretario | The Old Farmhouse Easter Balgedie KY13 9HQ Kinross | British | 104931180001 | ||||||
| HARDMAN, John Benjamin | Secretario | Hill Rise Burbage LE10 2UA Hinckley 42 Leicestershire United Kingdom | British | 131024350001 | ||||||
| PARKINSON, Ian | Secretario | 17 South Green LA12 0UJ Ulverston Cumbria | British | 100921910001 | ||||||
| RAMSAY, Fiona Ann | Secretario | The Courtyard Main Street KY9 1LG Kilconquhar Fife | British | 40987540003 | ||||||
| SIMMONS, Susan | Secretario | Reservoir Farm Church Street Naseby NN6 6DA Northampton Northamptonshire | British | 125431690001 | ||||||
| THOMAS, Hywel David | Secretario | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh | British | 59274640002 | ||||||
| WITTS, Kevan | Secretario | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | 190944710001 | |||||||
| ARTHUR, Nigel John | Director | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | England | English | 175689210001 | |||||
| BROWN, David John | Director | 49 Corstorphine Hill Gardens EH12 6LB Edinburgh Midlothian | Scotland | Scottish | 69967190001 | |||||
| BURTON, William John | Director | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh | England | British | 64885440001 | |||||
| COE, Albert Henry | Director | Finvara Blackhurst Brow Wilmslow Road SK10 4QT Mottram St Andrew Cheshire | United Kingdom | British | 3977310002 | |||||
| FOSTER, Stephen Albert | Director | The Lymes 295 Gisburn Road BB9 6AW Barrowford Lancashire | United Kingdom | British | 94033560001 | |||||
| GADSBY, Christopher James | Director | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | England | British | 118396090002 | |||||
| GREEN, Patricia Madeleine | Director | The Old Farmhouse Easter Balgedie KY13 9HQ Kinross | Scotland | British | 104931180001 | |||||
| GREEN, Richard John | Director | The Old Farmhouse Easter Balgedie KY13 9HQ Kinross | Scotland | British | 104931190001 | |||||
| PARKINSON, Ian | Director | 17 South Green LA12 0UJ Ulverston Cumbria | British | 100921910001 | ||||||
| RAMSAY, Fiona Ann | Director | The Courtyard Main Street KY9 1LG Kilconquhar Fife | Scotland | British | 40987540003 | |||||
| SIMMONS, Susan | Director | Reservoir Farm Church Street Naseby NN6 6DA Northampton Northamptonshire | England | British | 125431690001 | |||||
| SPRIGGS, Pauline Ann | Director | Poppinwell House The Limes LE16 7UN Thorpe Langton Leicestershire | United Kingdom | British | 47259460001 | |||||
| THOMAS, Hywel David | Director | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh | England | British | 59274640002 | |||||
| WATTS, Mark Bingham Titus | Director | May Tree Lodge Newlands, Naseby NN6 6DE Northampton | United Kingdom | British | 43948350004 | |||||
| WITTS, Kevan Ronald | Director | Castle Terrace EH1 2DB Edinburgh 20 Scotland | England | British | 83156160001 |
¿Tiene BLUE CHIP TRAVEL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 14 jul 1993 Entregado el 21 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 37 hill street north lane, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 23 ene 1991 Entregado el 30 ene 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 15 hill street edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 07 feb 1989 Entregado el 15 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Office premises 15 hill street, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 31 ene 1989 Entregado el 07 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0