RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)

RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC077737
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    Dirección de la sede social
    1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    Scotland
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Orden judicial

    Scheme of arrangement
    8 páginasOC

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued
    1 páginasGAZ2

    Orden judicial

    Diss by c/order
    8 páginasOC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Amalgamation between company and schlumberger uk holdings LTD 17/11/2023
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christopher Allan Walker como director el 18 ago 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Giselle Evette Varn como director el 04 ago 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Colin David Beddall como director el 31 jul 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gary Park como director el 31 jul 2022

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Schlumberger Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2022

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mikki Victoria Corcoran como director el 04 feb 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como director el 30 jul 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 30 jul 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Mikki Victoria Corcoran el 15 mar 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Giselle Evette Varn el 15 mar 2021

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL a 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ el 15 mar 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Giselle Evette Varn como director el 18 ene 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Simon Smoker como secretario el 29 may 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 29 may 2020

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Gary Park como director el 29 may 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BEDDALL, Colin David, Mr.
    Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    29
    United Kingdom
    Director
    Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    29
    United Kingdom
    United KingdomBritish287316070001
    WALKER, Christopher Allan
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Director
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandAmerican299227560001
    BRUCE, Gordon Alexander
    18 Reidford Gardens
    Drumoak
    AB31 5AW Banchory
    Kincardineshire
    Secretario
    18 Reidford Gardens
    Drumoak
    AB31 5AW Banchory
    Kincardineshire
    British120448390001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    168150570002
    HENDRY, Eric George
    School Road
    Newmachar
    AB21 0WB Aberdeen
    19
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Secretario
    School Road
    Newmachar
    AB21 0WB Aberdeen
    19
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    British139588340001
    HIGGINS, Mark Roman
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Secretario
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    270743080001
    LEYS, Michael Cheyne
    125 Hamilton Place
    AB2 4BD Aberdeen
    Secretario
    125 Hamilton Place
    AB2 4BD Aberdeen
    British3742210004
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    203976100001
    BARR, Lawrence Robert
    Findon
    AB12 4RL Aberdeen
    Blackhill Steading East
    Aberdeenshire
    Great Britain
    Director
    Findon
    AB12 4RL Aberdeen
    Blackhill Steading East
    Aberdeenshire
    Great Britain
    United KingdomBritish96384280001
    BERG, Jorgen
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Director
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    United KingdomDanish177176120001
    BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomFrench216352570001
    BRUCE, Gordon Alexander
    18 Reidford Gardens
    Drumoak
    AB31 5AW Banchory
    Kincardineshire
    Director
    18 Reidford Gardens
    Drumoak
    AB31 5AW Banchory
    Kincardineshire
    British120448390001
    BRUCE, Ronald James
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    Director
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish67939110001
    CHANDLER, Richard
    7310 Foster Island Drive
    Richmond
    Texas 77469
    Usa
    Director
    7310 Foster Island Drive
    Richmond
    Texas 77469
    Usa
    UsaAmerican113233060001
    CORCORAN, Mikki Victoria
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Director
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish261075650001
    DUDMAN, Bryan Leigh
    Cr 444 Waelder
    78959
    Texas
    5974
    Us
    Director
    Cr 444 Waelder
    78959
    Texas
    5974
    Us
    UsaAmerican137079030001
    HENDRY, Eric George
    School Road
    Newmachar
    AB21 0WB Aberdeen
    19
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Director
    School Road
    Newmachar
    AB21 0WB Aberdeen
    19
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139588340001
    HIGGINS, Mark Roman
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish256940520001
    HOEING-COSENTINO, Karin Annette
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    ScotlandGerman183326450001
    JOHNSTON, Gregory
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    Director
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    United KingdomIrish172272950001
    KIDD, Ryan Alexander
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish192568420001
    LAU, Werner
    Grange Lodge South Avenue
    Cults
    AB1 9LP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Grange Lodge South Avenue
    Cults
    AB1 9LP Aberdeen
    Aberdeenshire
    West German3742290001
    LEYS, Michael Cheyne
    15 West Cults Road
    Cults
    AB15 9HQ Aberdeen
    Director
    15 West Cults Road
    Cults
    AB15 9HQ Aberdeen
    ScotlandBritish3742210006
    MARSH, David
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish171331520001
    MCGACHIE, John
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    Director
    Badentoy Industrial Park
    Portlethen Industrial Estate
    AB12 4YB Portlethen, Aberdeen
    Badentoy Avenue
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish187731560001
    MCROBERTS, James Greer
    Alford House One Alford Place
    AB1 1YB Aberdeen
    Director
    Alford House One Alford Place
    AB1 1YB Aberdeen
    British53510790001
    NICHOLSON, Peter Duncan
    The Lilies
    20 Bath Street
    AB39 2DH Stonehaven
    Director
    The Lilies
    20 Bath Street
    AB39 2DH Stonehaven
    ScotlandBritish48078570002
    PAISLEY, Martin William
    Cairndow
    PH33 6SD Onich
    West Highlands
    Director
    Cairndow
    PH33 6SD Onich
    West Highlands
    British113228990001
    PARK, Gary
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritish270424580001
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish134158640002
    STEINKAMP, Manfred Theodor
    Westwinds Cammachmore
    Stonehaven
    Aberdeen
    Director
    Westwinds Cammachmore
    Stonehaven
    Aberdeen
    West German3742280001
    SUTTON, Neal
    County Road 242
    Shiro
    77876 Texas
    P O Box 10
    Usa
    Director
    County Road 242
    Shiro
    77876 Texas
    P O Box 10
    Usa
    American50209290001
    VARN, Giselle Evette
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Director
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandAmerican273564740002
    WERNER, Richard
    3507 Newcastle Drive
    77027 Houston
    Texas
    Usa
    Director
    3507 Newcastle Drive
    77027 Houston
    Texas
    Usa
    American50209320002
    WILDE, Geraldine
    2819 Hazy Hillside Ct
    77345 Kingwood
    Tx
    Usa
    Director
    2819 Hazy Hillside Ct
    77345 Kingwood
    Tx
    Usa
    UsaAmerican56051310001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Manor Royal
    RH10 9BU Crawley
    Minerva
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Manor Royal
    RH10 9BU Crawley
    Minerva
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07373289
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 23 nov 1988
    Entregado el 01 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease of ground on the southside of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen.
    Personas con derecho
    • Algemene Bank Nederland N.V.
    Transacciones
    • 01 dic 1988Registro de una carga
    • 22 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 14 nov 1988
    Entregado el 21 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Algemene Bank Nederland N.V.
    Transacciones
    • 21 nov 1988Registro de una carga
    • 22 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 19 ene 1984
    Entregado el 31 ene 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    0.9 acres situated on or towards the south side of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 31 ene 1984Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 09 sept 1983
    Entregado el 20 sept 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 20 sept 1983Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0