RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC077737 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Dirección de la sede social | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden judicial Scheme of arrangement | 8 páginas | OC | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Orden judicial Diss by c/order | 8 páginas | OC | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Allan Walker como director el 18 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Giselle Evette Varn como director el 04 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Colin David Beddall como director el 31 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Park como director el 31 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Schlumberger Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mikki Victoria Corcoran como director el 04 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como director el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Mikki Victoria Corcoran el 15 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Giselle Evette Varn el 15 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL a 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ el 15 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Giselle Evette Varn como director el 18 ene 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Smoker como secretario el 29 may 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 29 may 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Gary Park como director el 29 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDDALL, Colin David, Mr. | Director | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 287316070001 | |||||
| WALKER, Christopher Allan | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 299227560001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Secretario | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 168150570002 | |||||||
| HENDRY, Eric George | Secretario | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | British | 139588340001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Secretario | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270743080001 | |||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Secretario | 125 Hamilton Place AB2 4BD Aberdeen | British | 3742210004 | ||||||
| SMOKER, Simon | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203976100001 | |||||||
| BARR, Lawrence Robert | Director | Findon AB12 4RL Aberdeen Blackhill Steading East Aberdeenshire Great Britain | United Kingdom | British | 96384280001 | |||||
| BERG, Jorgen | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | United Kingdom | Danish | 177176120001 | |||||
| BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | 216352570001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Director | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| BRUCE, Ronald James | Director | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 67939110001 | |||||
| CHANDLER, Richard | Director | 7310 Foster Island Drive Richmond Texas 77469 Usa | Usa | American | 113233060001 | |||||
| CORCORAN, Mikki Victoria | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 261075650001 | |||||
| DUDMAN, Bryan Leigh | Director | Cr 444 Waelder 78959 Texas 5974 Us | Usa | American | 137079030001 | |||||
| HENDRY, Eric George | Director | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139588340001 | |||||
| HIGGINS, Mark Roman | Director | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | 256940520001 | |||||
| HOEING-COSENTINO, Karin Annette | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | German | 183326450001 | |||||
| JOHNSTON, Gregory | Director | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | Irish | 172272950001 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| LAU, Werner | Director | Grange Lodge South Avenue Cults AB1 9LP Aberdeen Aberdeenshire | West German | 3742290001 | ||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Director | 15 West Cults Road Cults AB15 9HQ Aberdeen | Scotland | British | 3742210006 | |||||
| MARSH, David | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| MCGACHIE, John | Director | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 187731560001 | |||||
| MCROBERTS, James Greer | Director | Alford House One Alford Place AB1 1YB Aberdeen | British | 53510790001 | ||||||
| NICHOLSON, Peter Duncan | Director | The Lilies 20 Bath Street AB39 2DH Stonehaven | Scotland | British | 48078570002 | |||||
| PAISLEY, Martin William | Director | Cairndow PH33 6SD Onich West Highlands | British | 113228990001 | ||||||
| PARK, Gary | Director | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 270424580001 | |||||
| SMOKER, Simon | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| STEINKAMP, Manfred Theodor | Director | Westwinds Cammachmore Stonehaven Aberdeen | West German | 3742280001 | ||||||
| SUTTON, Neal | Director | County Road 242 Shiro 77876 Texas P O Box 10 Usa | American | 50209290001 | ||||||
| VARN, Giselle Evette | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 273564740002 | |||||
| WERNER, Richard | Director | 3507 Newcastle Drive 77027 Houston Texas Usa | American | 50209320002 | ||||||
| WILDE, Geraldine | Director | 2819 Hazy Hillside Ct 77345 Kingwood Tx Usa | Usa | American | 56051310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlumberger Uk Limited | 06 abr 2016 | Manor Royal RH10 9BU Crawley Minerva United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 23 nov 1988 Entregado el 01 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Lease of ground on the southside of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 14 nov 1988 Entregado el 21 nov 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 19 ene 1984 Entregado el 31 ene 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción 0.9 acres situated on or towards the south side of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 09 sept 1983 Entregado el 20 sept 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0