THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC077741 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4th Floor Saltire Court EH1 2EN 20 Castle Terrace Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2015 | 14 páginas | AR01 | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Mark John Houston como director el 24 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Henrietta May Dundas-Bekker como director el 24 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2014, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2013 | 12 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2013, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2012 | 13 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Thomas Flockhart como director | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Graham como director | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2012, aucune liste de membres fournie | 8 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2011 | 13 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mark John Houston como director | 3 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2010 | 13 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2011, aucune liste de membres fournie | 8 páginas | AR01 | ||
Cese del nombramiento de Natasha Marshall como director | 2 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 28 feb 2010 au 31 ago 2010 | 3 páginas | AA01 | ||
Déclaration annuelle établie au 17 may 2010, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Natasha Ann Fullerton el 03 sept 2009 | 1 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Christopher Tiso el 17 may 2010 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2009 | 13 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de John Kennedy como director | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE SCOTTISH BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD TRUST LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||
| HUGHES, David | Director | 75 Morningside Drive EH10 5NJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 67524900001 | |||||
| TISO, Christopher | Director | Head Office 41 Commercial Street EH6 6JD Edinburgh Tiso Group Ltd Scotland | United Kingdom | British | 81984640002 | |||||
| DUNDAS & WILSON CS | Secretario corporativo | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 57627470001 | |||||||
| BARBER, Joe Millar | Director | Bridgelands TD7 4PT Selkirk | British | 781870001 | ||||||
| BAXTER, William Gordon | Director | Speybank IV32 7HH Fochabers Moray | Scotland | British | 203580001 | |||||
| BIRRELL, David | Director | 36 East Barnton Avenue EH4 6AQ Edinburgh | British | 115290001 | ||||||
| BOWES-LYON, David James | Director | Heriot Water EH38 5YE Heriot Midlothian | Scotland | British | 50820001 | |||||
| BURNET, Jeremy Morton | Director | 33 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 7470002 | ||||||
| CRICHTON STUART, John, Marquess Of Bute | Director | Mount Stuart PA20 9LR Rothesay Isle Of Bute | British | 35055270001 | ||||||
| DUNDAS-BEKKER, Althea Enid Phillipa | Director | Arniston House EH23 4RY Gorebridge Midlothian | Scotland | British | 11769930001 | |||||
| DUNDAS-BEKKER, Althea Enid Phillipa | Director | Arniston House EH23 4RY Gorebridge Midlothian | Scotland | British | 11769930001 | |||||
| DUNDAS-BEKKER, Henrietta May | Director | Arniston House EH23 4RY Gorebridge Midlothian | Scotland | British | 117613400001 | |||||
| FARMER, Thomas, Sir | Director | 192 Queensferry Road EH4 6JL Edinburgh Maidencraig House Midlothian | Scotland | British | 94804240004 | |||||
| FINDLAY, Richard | Director | Woodville 20 Laverockbank Road EH5 3DE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 35695630001 | |||||
| FLOCKHART, Thomas | Director | Sarlea 30 Kings Road EH32 0NN Longniddry East Lothian | United Kingdom | British | 933300001 | |||||
| GOODWIN, Frederick Anderson, Sir | Director | Gogarpark House Gogarburn EH12 1RB Edinburgh Midlothian | British | 56812920002 | ||||||
| GRAHAM, Robert Bishop | Director | Kenilworth Road FK9 4DU Bridge Of Allan Viewforth 2 Stirlingshire | United Kingdom | British | 49905230006 | |||||
| GRANT, Ian David, Sir | Director | Leal House Loyal Road Alyth PH11 8JQ Blairgowrie Perthshire | United Kingdom | British | 1304830002 | |||||
| GRANT, Matthew Alistair, Sir | Director | 16 Campden Hill Square Kensington W8 7JY London | British | 11265430001 | ||||||
| HOUSTON, Mark John | Director | 1 Langhaul Court G53 7RU Glasgow Charis Scotland | United Kingdom | British | 160439870001 | |||||
| HUNTER, Thomas Blane, Sir | Director | Ladykirk House Ladykirk Estate KA9 2SF Monkton | United Kingdom | British | 97904280003 | |||||
| IRVINE ROBERTSON, Alistair Duncan | Director | Arniston Home Farm EH23 4RY Gorebridge Midlothian | British | 53461410001 | ||||||
| KENNEDY, John Anthony Bingham | Director | Newhall Carlops EH26 9LY Penicuik Midlothian | Scotland | British | 71043680001 | |||||
| LOGAN, Joseph Andrew | Director | 2 Bishops Hill Acomb NE46 4NH Hexham Northumberland | British | 14123360002 | ||||||
| MACFARLANE OF BEARSDEN, Lord | Director | 50 Manse Road Bearsden G61 3PN Glasgow Strathclyde Scotland | British | 51933510001 | ||||||
| MARSHALL, Natasha Ann | Director | North Gardner Street G11 5BU Glasgow Flat 2/2 13 Strathclyde | Scotland | British | 74015640002 | |||||
| MOULSDALE, David Charles | Director | Fairhill House Prospect Road, Dullatur G68 0AN Glasgow | British | 69808430005 | ||||||
| MURRAY, David Edward, Sir | Director | 8a Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | Scotland | British | 34535230001 | |||||
| REID, Brian Henry | Director | 7 Anne House Bells Wynd 146 High Street EH1 1QY Edinburgh Lothian | British | 35055240001 | ||||||
| RIDLEY THOMAS, Roger | Director | Booton Manor Booton NR10 4NZ Reepham Norfolk | British | 34045870002 | ||||||
| SCOTT, Malcolm James | Director | Hill House Main Street EH27 8DR Kirknewton | Scotland | British | 57948650003 | |||||
| SOUTER, Brian, Sir | Director | Craigroyston 125 Glasgow Road PH2 0LU Perth Perthshire | United Kingdom | British | 1436810002 | |||||
| THOMPSON, Hugh Macrae | Director | Oak Ridge,Roundabout Copse West Chiltington RH20 2RN Pulborough West Sussex | British | 4959050010 | ||||||
| WEBSTER, David Gordon Comyn | Director | Rodinghead Ashridge Park HP4 1NP Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 14033120001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0