ROYAL SCOT LEASING LIMITED

ROYAL SCOT LEASING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROYAL SCOT LEASING LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC080104
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rbs Gogarburn
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta06 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence20 nov 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta06 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Gabriella Mary Silvester como director el 25 jul 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Amy Louise Noble como director el 25 jul 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Gerald Harris como director el 14 jul 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Emma-Marie Mayes como director el 13 may 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2024

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2024 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Lynn Mckirkle como director el 30 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Amy Noble como director el 25 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 nov 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Lynn Mckirkle el 30 jun 2022

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021

    19 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    33 páginasMA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 13 dic 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Natwest Group Secretarial Services Limited el 03 ago 2020

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Mrs Emma-Marie Mayes el 06 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ian Andrew Ellis el 06 sept 2021

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Royal Bank Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 ago 2020

    2 páginasPSC05

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020

    20 páginasAA

    Nombramiento de Lynn Mckirkle como director el 05 mar 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretario corporativo
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registroSC269847
    169073830002
    ELLIS, Ian Andrew
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish243996550001
    HARRIS, David Gerald
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish236842580001
    SILVESTER, Gabriella Mary
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    EnglandBritish338481080001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DOWN, Carolyn Jean
    Floor
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th
    England
    Secretario
    Floor
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th
    England
    Other67499700004
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Secretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    TALBOT, Alan William
    1 The Chesils
    Greet
    GL54 5NW Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    1 The Chesils
    Greet
    GL54 5NW Cheltenham
    Gloucestershire
    British3769650001
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Secretario
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    BROWN, Martin Graham
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    Director
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    British36168760001
    CARR, Thomas
    4 Admirals Court
    Eastbury Avenue
    HA6 3JP Northwood
    Middlesex
    Director
    4 Admirals Court
    Eastbury Avenue
    HA6 3JP Northwood
    Middlesex
    British656980011
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Director
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Director
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    Director
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    United KingdomBritish49141230004
    CONNER, Lynne
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish264481220001
    CROME, Trevor Douglas
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    Director
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    EnglandBritish186705800001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Director
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    British96634670001
    ELDER, Davies Burns
    Flat 9 Cathedral Lodge
    110-115 Aldersgate Street
    EC1A 4JE London
    Director
    Flat 9 Cathedral Lodge
    110-115 Aldersgate Street
    EC1A 4JE London
    British70027580001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FLINT, Eion Arthur Mcmorran
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    British56760630002
    FREEBOROUGH, Christopher Rupert
    The Malthouse The Green
    Sheepscombe
    GL6 7RG Stroud
    Gloucestershire
    Director
    The Malthouse The Green
    Sheepscombe
    GL6 7RG Stroud
    Gloucestershire
    British68451360002
    GADSBY, Andrew Paul
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    Director
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    EnglandBritish74834980002
    HARRIS, David Gerald
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish236842580001
    HAWKINS, Gary Lionel
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish203925910001
    JOHNSON, Alan Piers
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    Director
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    EnglandBritish155895050001
    LATTER, William Vaughan
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British52914600004
    MAYES, Emma-Marie
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish258397370001
    MAYES, Emma-Marie
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    Director
    24/25 St Andrew Square
    Edinburgh
    EH2 1AF
    United KingdomBritish258397370001
    MCDAID, Neil Jason
    EC2M 4RB London
    250 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 4RB London
    250 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish222279310001
    MCKIRKLE, Lynn
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish280898060002
    NOBLE, Amy Louise
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    EnglandBritish326877560001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Director
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    ROGERS, Julian Edwin
    2 The Green
    RM15 6SD South Ockendon
    Nubbock House
    Essex
    England
    Director
    2 The Green
    RM15 6SD South Ockendon
    Nubbock House
    Essex
    England
    EnglandBritish137180040001
    ROULSTON, Steven James
    Ground Floor, Business House F
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    Scotland
    Director
    Ground Floor, Business House F
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    Scotland
    ScotlandBritish238205130001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROYAL SCOT LEASING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    06 abr 2016
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Companies Acts
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc058013
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0