DENHOLM CONTRACTING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DENHOLM CONTRACTING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC083579 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O JOHNSTON CARMICHAEL 7-11 Melville Street EH3 7PE Edinburgh Midlothian |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DENHOLM INDUSTRIAL SERVICES LIMITED | 02 dic 1994 | 02 dic 1994 |
| BION LIMITED | 17 jun 1983 | 17 jun 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 13 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 18 Woodside Crescent Glasgow G3 7UL a 7-11 Melville Street Edinburgh Midlothian EH3 7PE el 19 oct 2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Luke Preston el 11 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Mcilduff como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen David Jenkins como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Anthony Hill como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevon Peter Daymond como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Luke Preston como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Damian Lee O'brien como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Benjamin Donald Robert Maclehose como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed denholm industrial services LIMITED\certificate issued on 01/07/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Macgregor Mcfadyen como director el 21 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Craig David George Daniels como secretario el 31 dic 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gregory Albert Hanson como secretario el 31 dic 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Thomas Mcilduff el 24 nov 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELS, Craig David George | Secretario | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | 278259340001 | |||||||
| MACLEHOSE, Benjamin Donald Robert | Director | The Aspect 12 Finsbury Square EC2A 1AS London 8th Floor United Kingdom | England | British | 182762200005 | |||||
| PRESTON, Simon Luke | Director | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 208194360002 | |||||
| CARRINGTON, Linda | Secretario | 2 Camborne Place BA21 5DQ Yeovil Somerset | British | 101180630001 | ||||||
| HANSON, Gregory Albert | Secretario | 18 Woodside Crescent Glasgow G3 7UL | British | 66554810001 | ||||||
| HANSON, Gregory Albert | Secretario | 4 Greenlaw Drive Newton Mearns G77 6NL Glasgow | British | 66554810001 | ||||||
| PARKER, James Frederick Somerville | Secretario | The Moss Killearn G63 9LJ Glasgow Scotland | British | 11315830001 | ||||||
| PARKER, James Frederick Somerville | Secretario | The Moss Killearn G63 9LJ Glasgow Scotland | British | 11315830001 | ||||||
| POTTS, Graham Mark | Secretario | 8 Jasmine Close TA18 7DB Crewkerne Somerset | British | 2164270001 | ||||||
| SLACK, David William | Secretario | 33 Weavers Road PA2 9DP Paisley Renfrewshire | British | 786500001 | ||||||
| BEVERIDGE, Michael John | Director | Park View 13 Park Circus G3 6AX Glasgow Apartment 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 73522190007 | |||||
| BONACCORSI, David | Director | 44 Leapmoor Drive Wemyss Bay PA18 6BT Inverclyde | British | 28468160003 | ||||||
| CLUNIE, Patrick David | Director | 10 Waterford Close TA6 6UN Bridgwater Somerset | England | British | 62004880001 | |||||
| DAYMOND, Kevon Peter | Director | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 169900900001 | |||||
| DAYMOND, Kevon Peter | Director | Brooklands PL21 0EA Bittaford Devon | British | 100396440001 | ||||||
| DENHOLM, John Stephen | Director | Balfron G63 0QP Glasgow Camoquhill Douglas | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DENHOLM, John Stephen | Director | Camoquhill Douglas Balfron G63 0QP Glasgow | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DENHOLM, John Stephen | Director | Camoquhill Douglas Balfron G63 0QP Glasgow | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DEVLIN, Charles | Director | 177 Avontoun Park EH49 6QH Linlithgow West Lothian | British | 71102380001 | ||||||
| FISHER, Paul Matthew | Director | Heathfield 53 Furzehatt Road PL9 8QX Plymstock Devon | England | British | 139740040001 | |||||
| GARDNER, Paul Vernon | Director | Westhayes Westhill EX11 1UZ Ottery St Mary Devon | British | 69941350002 | ||||||
| GILBERT, Harry | Director | Yew Tree House Nantwich Road, Wrenbury CW5 8ED Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 83163120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Director | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HILL, Stephen Anthony | Director | Barracks Close Lufton Trading Estate BA22 8RN Yeovil 1 Somerset United Kingdom | England | British | 224810240001 | |||||
| JENKINS, Stephen David | Director | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 208194440001 | |||||
| MACLEHOSE, Benjamin Donald Robert | Director | The Aspect 12 Finsbury Square EC2A 1AS London 8th Floor United Kingdom | England | British | 182762200003 | |||||
| MALKIN, Andrew | Director | 10 Cadell Loan Doune FK16 6BD Stirling Perthshire | British | 81846450001 | ||||||
| MCFADYEN, William Macgregor | Director | Carmichael Street G51 2QU Glasgow 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 182762210001 | |||||
| MCILDUFF, Thomas | Director | Carmichael Street G51 2QU Glasgow 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 122802910004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DENHOLM CONTRACTING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denholm Industrial Services (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DENHOLM CONTRACTING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 24 dic 2009 Entregado el 30 dic 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 24 dic 2009 Entregado el 30 dic 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 01 oct 1983 Entregado el 10 oct 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene DENHOLM CONTRACTING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0