SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC086166 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tlt Llp 140 West George Street G2 2HG Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| S&N PUBS AND RESTAURANTS LIMITED | 26 oct 2001 | 26 oct 2001 |
| SCOTTISH & NEWCASTLE RETAIL LIMITED | 18 jun 1991 | 18 jun 1991 |
| LAXERT LIMITED | 10 ene 1984 | 10 ene 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 22 ago 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria | 11 páginas | 4.26(Scot) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2016 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Lindsay Anne Keswick como secretario el 25 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario el 25 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 ago 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Robert Langford como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daryl Antony Kelly como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lucy Jane Bell como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Kirk Dyson Davis como director el 21 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henry Jones como secretario el 04 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 24 ago 2016 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick James Gallagher como director el 23 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 ago 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 21 York Place Edinburgh EH1 3EN a Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG el 01 sept 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 17 ago 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Rudd como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Henry Jones como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secretario | 140 West George Street G2 2HG Glasgow Tlt Llp | 207523740001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| BOLTON, George Francis | Secretario | 61 Comiston View EH10 6LZ Edinburgh Midlothian | British | 6950001 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secretario | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592230001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172446760001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretario | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021800001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Director | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CRICHTON, Roger Wells | Director | Pitsford House West Manor Road, Pitsford NN6 9AR Northampton Northamptonshire | British | 67937290001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Director | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIDSON, Angus Neil | Director | High Camilty Harburn EH55 8RH West Calder | British | 26376890001 | ||||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| EDWARDS, David James | Director | Greencroft 38 Dunbar Road EH41 3PJ Haddington East Lothian | British | 9489100001 | ||||||
| FLEMING, John William Robert | Director | The Garth Lands Lane HG5 9DE Knaresborough North Yorkshire | British | 39827670001 | ||||||
| FRASER, Stanley Durward | Director | 7 Murrayfield Drive EH12 6EB Edinburgh Midlothian | British | 189330001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GEIB, Paul | Director | Redbourne Castle Hill SK10 4AS Prestbury Cheshire | British | 34477180001 | ||||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| GRACE, David Allen | Director | Conservatory Apartments 1 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | British | 67926560002 | ||||||
| HANNAH, Ian George | Director | White Dell Farm Belsize WD3 4NX Sarratt Hertfordshire | British | 37054780003 | ||||||
| HAUPT, Stephen Edward | Director | The Owls Nest Market Square, Lower Heyford OX6 3NY Bicester Oxfordshire | British | 68466580001 | ||||||
| HIELD, Timothy Peter | Director | 20 Cluny Drive EH10 6DP Edinburgh | British | 26376950002 | ||||||
| HOLTHAM, Robert William | Director | The Coppice 3 Dorridge Croft B93 8QL Solihull West Midlands | British | 40415840002 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Director | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| IVELL, Robert Lewis | Director | Boltons Hill Barham Road PE28 0YT Spaldwick Cambridgeshire | United Kingdom | English | 96389110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Retail Bidco Limited | 06 abr 2016 | Westgate Street IP33 1QT Bury St. Edmunds Westgate Brewery Suffolk England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0