COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC087432 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 6-8 George Street EH2 2PF Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ADAM & COMPANY (NOMINEES)LIMITED | 30 mar 1984 | 30 mar 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Claire Middleton como director el 01 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Steven Barr como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Richard Steven Barr como director el 13 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Middleton como director el 13 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 34 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 nov 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Dennis Ray como director el 05 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Coutts & Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed adam & company (nominees)LIMITED\certificate issued on 05/09/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Claire Middleton como director el 05 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Alisdair Matthew Dewar como director el 10 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edmund Ridout Harvey-Jamieson como director el 28 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Natwest Group Secretarial Services Limited el 03 ago 2020 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Dennis Ray el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| DEWAR, Alisdair Matthew | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | United Kingdom | British | 296795620001 | |||||||||
| MIDDLETON, Claire | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 343199180001 | |||||||||
| DOYLE, Sally Anne | Secretario | Maple Road SE20 8HE London 68 England | 152595480001 | |||||||||||
| GOW, Morven | Secretario | PO BOX 1000 EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 209091850001 | |||||||||||
| HARTOP, Graeme Thomas | Secretario | 18a Manor Place EH3 7DS Edinburgh Midlothian | British | 891110001 | ||||||||||
| LOWRY, Jeremy Malbon | Secretario | 3 Clermiston Terrace EH12 6XF Edinburgh Midlothian | British | 197600001 | ||||||||||
| MASSIE, Scott Edward | Secretario | 58 Thirlestane Road EH9 1AR Edinburgh Midlothian | British | 31277850001 | ||||||||||
| MCDONALD, Ross Douglas | Secretario | 15 Burngrange Park EH55 8ET West Calder West Lothian | British | 86386010002 | ||||||||||
| STANWORTH, William John | Secretario | Highfield House 194 Main Street EH37 5SG Pathhead Midlothian | British | 41736370002 | ||||||||||
| BARR, Richard Steven | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 324528590001 | |||||||||
| DALZIEL, Ian Martin | Director | 52 Perrymead Street SW6 3SP London | British | 1331330001 | ||||||||||
| DONALDSON, Richard Edwards | Director | Lichfield Gardens TW9 1AP Richmond 50 Surrey | United Kingdom | British | 68192970003 | |||||||||
| DUDGEON, Alexander Stewart | Director | 8 Cluny Drive EH10 6DN Edinburgh Midlothian | British | 61131230002 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Raymond Marvin | Director | The Glebe Lauder TD2 6RW Berwickshire | Scotland | British | 892520001 | |||||||||
| GARLAND, David Anthony | Director | Chaucer Villas Chaucer Road BA2 4QY Bath 2 England | England | British | 150872770001 | |||||||||
| GRAHAM, Donald, Lord | Director | Nether Tillyrie KY13 0RW Milnathort Kinross-Shire | United Kingdom | British | 1385490001 | |||||||||
| HARVEY-JAMIESON, Edmund Ridout | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 194155630001 | |||||||||
| HEDDERWICK, Alexander Mark | Director | Gifford Bank Edinburgh Road EH41 4JE Gifford East Lothian | United Kingdom | British | 89989960001 | |||||||||
| HERON, Douglas Nicol | Director | St. Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 25 | Scotland | British | 184622430001 | |||||||||
| HOUSE, Mark Andrew Daryl | Director | Strand WC2R 0QS London 440 England | England | British | 163434110002 | |||||||||
| LAURENSON, James Tait | Director | Hillhouse EH27 8DR Kirknewton Midlothian | British | 338250001 | ||||||||||
| LOWRY, Jeremy Malbon | Director | 3 Clermiston Terrace EH12 6XF Edinburgh Midlothian | British | 197600001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Claire | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 290535550001 | |||||||||
| NORFOLK, Jeremy Paul | Director | 8 Henderland Road EH12 6BB Edinburgh Midlothian | British | 37271240001 | ||||||||||
| RAY, Robert Dennis | Director | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | England | British | 86842140001 | |||||||||
| STANWORTH, William John | Director | Highfield House 194 Main Street EH37 5SG Pathhead Midlothian | United Kingdom | British | 41736370002 | |||||||||
| THORPE, David Robert | Director | Strand WC2R 0QS London 440 England | England | British | 152511790002 | |||||||||
| WALTERS, Christopher James | Director | Rickford Rise Burrington BS40 7AN Bristol Marchwood England | England | British | 152510200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coutts & Company | 04 sept 2022 | Strand WC2R 0QS London 440 Strand England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 01 oct 2017 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Midlothian Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Adam & Company Plc | 01 oct 2017 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Adam & Company Group Plc | 06 abr 2016 | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 25 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ctl Nominees Limited | 06 abr 2016 | King Street SW1Y 6QY London 22 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0