PROJECT ABILITY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PROJECT ABILITY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC087782 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PROJECT ABILITY LIMITED?
- Explotación de instalaciones artísticas (90040) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra PROJECT ABILITY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 103 Trongate G1 5HD Glasgow Lanarkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PROJECT ABILITY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PROJECT ABILITY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROJECT ABILITY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Murray Ferguson Wilson como secretario el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Roisin Murray como secretario el 22 sept 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Ann Margaret Downie como director el 22 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Louise Briggs como director el 22 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Colin Lamb como director el 18 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 32 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Louise Briggs como director el 24 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Catherine Ann Dowling como director el 24 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Irene Macdonald Brodie como director el 24 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Fiona Greer como director el 24 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 37 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Georgia Bridgwood como director el 16 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Carol Pert como director el 16 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Colin Lamb como director el 16 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Keith Thomas Wimbles como director el 14 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021 | 41 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Elizabeth Matheson como director el 17 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Ms Wendy Burton el 05 may 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PROJECT ABILITY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Roisin | Secretario | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | 340616530001 | |||||||
| BRODIE, Irene Macdonald | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 266715120001 | |||||
| BURTON, Wendy | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 256566100002 | |||||
| DOWLING, Catherine Ann | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | Scottish | 311688800001 | |||||
| GIBSON, Allison Grace Miller | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | United Kingdom | British | 240249470001 | |||||
| MCCONNELL, Maria Louise | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 240249740001 | |||||
| PERT, Carol | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 296180140001 | |||||
| DAVIS, Marion Elizabeth | Secretario | 24 Gibson Street Flat 2l G12 8NX Glasgow | British | 104457350001 | ||||||
| DICKSON, Graeme Ross Campbell | Secretario | 9 Cleveden Gardens G12 0PU Glasgow | British | 92403980001 | ||||||
| HENDERSON, Christine Selbie | Secretario | 1 Hollymount Bearsden G61 1DQ Glasgow | British | 322130003 | ||||||
| WILSON, Murray Ferguson | Secretario | Logan Drive KA10 6PW Troon 1 Ayrshire Scotland | British | 133550270001 | ||||||
| ADAMS, John Michael | Director | 8 North Gardiner Street G11 5BY Glasgow | British | 35454920001 | ||||||
| ALLAN, Elise Vivien | Director | 54 Vennard Gardens G41 2DA Glasgow Lanarkshire | British | 104457240001 | ||||||
| ANDREWS, Raymond P W | Director | Rockcliffe G60 5AA Bowling | British | 322160001 | ||||||
| BALLOCH, Amy | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 256566840001 | |||||
| BINGHAM, April | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 209054970001 | |||||
| BLEAU, Joanna | Director | 24 Carswell Gardens Strathbungo G41 2DH Glasgow Lanarkshire | British | 101180250001 | ||||||
| BRIDGWOOD, Georgia | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 276644590001 | |||||
| BRIGGS, Louise | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 311688850001 | |||||
| CARRELL, Ronald Christopher | Director | 30 Wansdown Crescent G12 Glasgow | British | 322150001 | ||||||
| COULTER, James Stewart | Director | 56 Great George Street G12 8LA Glasgow | Scotland | British | 57732620001 | |||||
| DAVIS, Marion Elizabeth | Director | Beaufort Avenue G43 2YL Glasgow 47 Scotland | Scotland | British | 104457350002 | |||||
| DOCHERTY, Frank Mclean | Director | 1 Hollymount Bearsden G61 1DQ Glasgow | British | 23060950003 | ||||||
| DOWNIE, Ann Margaret | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 256573900001 | |||||
| DOWNIE, Robin, Professor | Director | 17 Hamilton Drive G12 8DN Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 81290700001 | |||||
| DUPRE, Hilary Mary Hamilton | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 209054260001 | |||||
| EVANS-TEUSH, Bevis Gibson | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire Scotland | Scotland | United Kingdom | 168448040001 | |||||
| FEENEY, David, Dr | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire Scotland | Scotland | Irish | 159522850001 | |||||
| FOGG, David | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 240249140001 | |||||
| GLOVER, John Gordon | Director | Grendon 129 Sinclair Street G84 9AJ Helensburgh Dunbartonshire | British | 16810270001 | ||||||
| GODMAN, Patricia | Director | 21 Kensington Gate G12 9LQ Glasgow | British | 43265480001 | ||||||
| GRAVES, Lynn | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 159506270001 | |||||
| GREER, Fiona | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 256565670001 | |||||
| HAMILTON, Christine Millar | Director | 20 Caird Drive G11 5DT Glasgow | British | 56858190001 | ||||||
| HAMILTON, Laura Macalpin | Director | Trongate G1 5HD Glasgow 103 Lanarkshire | Scotland | British | 192088670001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PROJECT ABILITY LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 31 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0