BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC089468 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LENDLEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED | 01 jul 2016 | 01 jul 2016 |
| LEND LEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED | 28 feb 2011 | 28 feb 2011 |
| BOVIS LEND LEASE (SCOTLAND) LIMITED | 01 feb 2000 | 01 feb 2000 |
| BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED | 29 nov 1984 | 29 nov 1984 |
| QUITTE LIMITED | 29 ago 1984 | 29 ago 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Lendlease Construction Holdings (Europe) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2025 au 31 mar 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 mar 2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed lendlease construction (scotland) LIMITED\certificate issued on 01/04/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon William Gorski como director el 23 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de David Edward Cadiot como director el 16 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Tom Gillibrand como director el 05 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Nicola Bramble como director el 04 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Louise Nicola Bramble como director el 14 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michelle Gaye Letton como director el 14 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Dominic Leonard como director el 18 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lendlease, 77 Renfield Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH Scotland a 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH el 07 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon William Gorski el 10 feb 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADIOT, David Edward | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 281962250001 | |||||||||
| GILLIBRAND, Tom | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 303891700001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Laurence James | Secretario | 35 The Green Writtle CM1 3DT Chelmsford Essex | British | 580980001 | ||||||||||
| CHADWICK, Peter Roy | Secretario | 24 Pendarves Road Raynes Park SW20 8TS London | British | 37525040002 | ||||||||||
| CUTTS, Alistair | Secretario | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | British | 103721920002 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Secretario | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Dukes Place EC3A 7NH London 40 United Kingdom |
| 102944500001 | ||||||||||
| ALLPORT, Roy Innes | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | Scotland | British | 185943820001 | |||||||||
| ANDERSON, Gordon Adam | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 62089480001 | |||||||||
| ASH, Gordon Brian | Director | The Coach House Auchengillan G63 9AU Blanefield Stirlingshire | British | 82612740001 | ||||||||||
| BALLANTYNE, John Charles | Director | 30 Rosemount Cumbernauld G68 0HL Glasgow | British | 53470410001 | ||||||||||
| BATE, Dennis | Director | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | 28569910001 | ||||||||||
| BRAMBLE, Louise Nicola | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 256411060001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Laurence James | Director | 35 The Green Writtle CM1 3DT Chelmsford Essex | British | 580980001 | ||||||||||
| COLEMAN, Murray Leslie | Director | Laurel House Queens Road TW10 6JJ Richmond Surrey | Australian | 114401640001 | ||||||||||
| COOK, George Lamond | Director | 75 Cash Feus Strathmiglo KY14 7QP Cupar Fife | Scotland | Scottish | 51373080001 | |||||||||
| DEW, Beverley Edward John | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 133103950001 | |||||||||
| DOWNIE, Henry Francis | Director | 42 Fountainhall Road EH9 2LW Edinburgh Midlothian | British | 1357800001 | ||||||||||
| DYKE, Michael Sean | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 187622030001 | |||||||||
| GANDY, Paul Francis | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 71452580002 | |||||||||
| GLEDHILL, Lisa Veronica | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 178456550002 | |||||||||
| GORSKI, Simon William | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 215280250003 | |||||||||
| GRIST, Stephen Kenneth | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | Australian | 157560950001 | |||||||||
| HARVEY, Colin Stephen | Director | 8 Montrose Close SK10 3QY Macclesfield Cheshire | England | British | 96158420001 | |||||||||
| HEYES, Michael | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 189835920001 | |||||||||
| HYNE, John Charles | Director | 6 Broomhill Park EH22 3JX Eskbank Midlothian | British | 100669250001 | ||||||||||
| JOHNSON, Paul Murray | Director | Ranelagh House 2 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | England | British | 115607320001 | |||||||||
| LABBAD, Daniel | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | Australian | 111679880003 | |||||||||
| LEONARD, Peter Dominic | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | United Kingdom | British | 280048870001 | |||||||||
| LETTON, Michelle Gaye | Director | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | Australian | 267826300001 | |||||||||
| MABEY, Roger Stanley | Director | Carrol Lodge Sutton Road SL6 9RD Cookham Village Berkshire | England | British | 156243050001 | |||||||||
| MACK, Alan Charles | Director | Manesty 18 Apperley Road NE43 7PG Stocksfield Northumberland | British | 81122300001 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Director | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 317424620001 | |||||||||
| MCMURDO, John Stuart | Director | Westlea 58 Majors Loan FK1 5QG Falkirk Stirlingshire | British | 78860160001 | ||||||||||
| MCQUADE, Brian | Director | 289 Main Road Elderslie PA5 9ED Johnstone | British | 75590650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovis Construction Holdings (Europe) Limited | 06 abr 2016 | Crown Place EC2A 4ES London 30 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0