VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC090543 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Brown Street Newmilns KA16 9AG Ayrshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COOKSON TECHNICAL CERAMICS EUROPE LIMITED | 03 oct 1988 | 03 oct 1988 |
| COORS CERAMICS EUROPE HOLDINGS LIMITED | 24 dic 1987 | 24 dic 1987 |
| COORS CERAMICS EUROPE LIMITED | 14 nov 1984 | 14 nov 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 07 dic 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Aashish Chimanlal Shah como director el 25 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian James Lawson como director el 31 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Christopher Upcott como director el 21 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 dic 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Jennifer Smith como secretario el 01 nov 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Murray como secretario el 01 nov 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Ian James Lawson como director | 6 páginas | RP04AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ian James Lawson como director el 05 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Kim Fong Siow como director el 21 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 dic 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Simon Upcott como director el 29 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Kim Fong Siow el 01 jul 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Jennifer | Secretario | EC4A 2AE London 165 Fleet Street England | 240019200001 | |||||||
| KNOWLES, Henry James | Director | EC4A 2AE London 165 Fleet Street England | United Kingdom | British | 49356830003 | |||||
| SHAH, Aashish Chimanlal | Director | Fleet Street EC4A 2AE London 165 United Kingdom | United Kingdom | British | 271505040001 | |||||
| FELL, Rachel Sara | Secretario | 27 Buckhurst Avenue TN13 1LZ Sevenoaks Kent | British | 73571090002 | ||||||
| FIRMAN, Angela June | Secretario | Brown Street Newmilns KA16 9AG Ayrshire | 178839730001 | |||||||
| GRIFFITHS, William Maxwell | Secretario | Windyridge 21 Upper Crofts Alloway KA7 4QX Ayr Ayrshire Scotland | British | 721430001 | ||||||
| JACKSON, Michael | Secretario | 5 Sunrise Avenue CM1 4JL Chelmsford Essex | British | 38260600001 | ||||||
| JENNINGS, Nicholas David De Burgh | Secretario | Fleet Street EC4A 2AE London 165 England | 177189020001 | |||||||
| KNOWLES, Henry James | Secretario | Fleet Street EC4A 2AE London 165 Fleet Street England | 186342690001 | |||||||
| MCDONNALL, Glen Michael | Secretario | Flat 11 22 Park Crescent Regents Park W1N 3PD London | British | 45168130001 | ||||||
| MURRAY, Dominic | Secretario | c/o Vesuvius Plc Fleet Street EC4A 2AE London 165 England | 188196040001 | |||||||
| WILLIAMS, Huw | Secretario | 18 Duffryn Close CF39 8HD Tonyrefail Rhondda Cynon Taff | British | 59448080001 | ||||||
| BROOK, Roger Walker | Director | Gowodean PA24 8AH Lochgoilhead Argyll | Scotland | British | 41245100001 | |||||
| ELLISTON, Bryan Richard | Director | Parkers Green Cottage Hadlow Road TN11 0AE Tonbridge Kent | England | British | 81507440001 | |||||
| FISHLER, Mark | Director | 2220 Sable Oaks FOREIGN Naperville Illinois 60564 Usa | American | 51688770002 | ||||||
| GRIFFITHS, William Maxwell | Director | Windyridge 21 Upper Crofts Alloway KA7 4QX Ayr Ayrshire Scotland | United Kingdom | British | 721430001 | |||||
| GROSSO, Roberto | Director | Avenue Des Torterelles 5 1950 Krainen Belgium | Italian | 17170040001 | ||||||
| JACKSON, Michael | Director | 5 Sunrise Avenue CM1 4JL Chelmsford Essex | British | 38260600001 | ||||||
| LAWSON, Ian James | Director | Brown Street Newmilns KA16 9AG Ayrshire | United Kingdom | British | 207123690001 | |||||
| MALHERBE, Jean-Pierre | Director | Avenue Des Buissons 35 1640 Rhode Saint Genese Belgium | Belgian | 58217380002 | ||||||
| MALTHOUSE, Richard Martin Hilary | Director | Westbury Station Road GU10 5JY Bentley Hampshire | England | British | 35211560001 | |||||
| MCDONNALL, Glen Michael | Director | Flat 11 22 Park Crescent Regents Park W1N 3PD London | British | 45168130001 | ||||||
| SIOW, Kim Fong | Director | Brown Street Newmilns KA16 9AG Ayrshire | United Kingdom | Malaysian | 187075200004 | |||||
| UPCOTT, Simon Christopher | Director | EC4A 2AE London 165 Fleet Street England | England | British | 272182520001 | |||||
| WILSON, Ian | Director | 55 Amherst Road CV8 1AG Kenilworth Warwickshire | British | 162980001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de VESUVIUS ZYALONS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesuvius Holdings Limited | 06 abr 2016 | EC4A 2AE London 165 Fleet Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0