SPINAL INJURIES SCOTLAND

SPINAL INJURIES SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPINAL INJURIES SCOTLAND
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC091206
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    Fullarton Court, Unit C
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SCOTTISH SPINAL CORD INJURY ASSOCIATION28 oct 198528 oct 1985
    SCOTTISH PARAPLEGIC (SPINAL INJURY) ASSOCIATION21 jun 198521 jun 1985
    SCOTTISH PARAPLEGIC (SPINAL INJURY) ASSOCIATION LIMITED THE11 ene 198511 ene 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 oct 2025
    Próxima declaración de confirmación vence14 nov 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 oct 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Douglas Bruce Ross como director el 04 feb 2025

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    36 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2024 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Christine Claire Dodds como director el 27 ago 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Julie Theresa Degnan como director el 27 ago 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    39 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    32 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2022 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mark Campbell Allen como director el 07 may 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    32 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2021 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de William Sutherland Dunnett como director el 22 sept 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Fraser John Payne como director el 11 may 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Campbell Allen como director el 01 dic 2020

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    32 páginasAA

    Cese del nombramiento de Patricia Mccaffery como director el 09 dic 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2020 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Patrick Francis Cairney como director el 18 ago 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Christine Claire Dodds como director el 17 ago 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr William Sutherland Dunnett como director el 07 jul 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kathleen Claire Mcmonagle como director el 28 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    28 páginasAA

    Cambio de datos del director Mrs Kathleen Claire Mcmonagle el 03 dic 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2019 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAIRNEY, Patrick Francis
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandScottishRetired275119940001
    DEGNAN, Julie Theresa
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandScottishHead Of Services326695750001
    MACSWEEN, Ann, Dr
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishHead Of Casework, Heritage Directorate, Historic E260942690001
    MCOUAT, Lucy
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishDigital Content And Programme Executive260942720001
    MORRISON, Evelyn
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandIrishPhysiotherapist224655610001
    ROSS, Douglas Bruce
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishManager329530050001
    ANDERSON, Elizabeth Wilma
    27 Weighhouse Close
    PA1 1AY Paisley
    Flat 1/1
    Renfrewshire
    Secretario
    27 Weighhouse Close
    PA1 1AY Paisley
    Flat 1/1
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant130268370001
    CARLTON, Blair Nicholas George
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Secretario
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    155581240001
    CONLON, James Kevin
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Secretario
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    194994710001
    KENEDI, Robert Maximilian
    3 Ladywood Manor Road
    Milngavie
    G62 8BE Glasgow
    Secretario
    3 Ladywood Manor Road
    Milngavie
    G62 8BE Glasgow
    BritishRetired1283320001
    MCCROSSIN, Francis Eugene Joseph
    Rowallan
    137 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    South Ayrshire
    Secretario
    Rowallan
    137 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    South Ayrshire
    BritishChartered Accountant81522360001
    MCGLYNN, Linda
    79 Parklands Oval
    G53 7UD Glasgow
    Secretario
    79 Parklands Oval
    G53 7UD Glasgow
    British125780320001
    ROBERTSON, George
    13 Lockharton Crescent
    EH14 1AX Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    13 Lockharton Crescent
    EH14 1AX Edinburgh
    Midlothian
    British302480001
    ALLAN, Jennifer Scott
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishService Development Manager185621870001
    ALLEN, Mark Campbell
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandScottishRetired281820630001
    ANDERSON, Elizabeth Wilma
    Weighhouse Close
    PA1 1AG Paisley
    Flat 1/1, 27
    Renfrewshire
    Director
    Weighhouse Close
    PA1 1AG Paisley
    Flat 1/1, 27
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant129673650001
    BAIRD, Sheena Mcroberts
    108 Fairview Circle
    Danestone
    AB22 8YR Aberdeen
    Director
    108 Fairview Circle
    Danestone
    AB22 8YR Aberdeen
    BritishP/T Lecturer58975730001
    BALDWIN, Carol Margaret
    32 Albert Drive
    Bearsden
    G61 2PG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    32 Albert Drive
    Bearsden
    G61 2PG Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCivil Servant790830001
    BAMFORD, Linda Miller
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandScottishTrustee193057700001
    BOWIE, Stuart James
    Burnbank
    Cairneyhill
    KY12 8FN Dunfermline
    3
    Scotland
    Director
    Burnbank
    Cairneyhill
    KY12 8FN Dunfermline
    3
    Scotland
    ScotlandBritishWarrant Officer - Hm Forces240766340001
    BROOKS, Lois
    15 Baker Street
    G41 3YA Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    15 Baker Street
    G41 3YA Glasgow
    Lanarkshire
    BritishSubtitler1166330001
    BROUSSARD, Joseph Patrick
    Eglinton House
    Eglinton Park
    KA13 7QA Kilwinning
    Ayrshire
    Director
    Eglinton House
    Eglinton Park
    KA13 7QA Kilwinning
    Ayrshire
    BritishSelf Employed50439740001
    BROWN, Linda Mitchell
    7 Cambridge Street
    DD2 1TA Dundee
    Angus
    Director
    7 Cambridge Street
    DD2 1TA Dundee
    Angus
    ScotlandBritishTeacher110750150001
    BYRNE, Clare
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    ScotlandBritishSelf Employed99455730001
    CADDEN, Helen Elizabeth Stewart
    153 Danes Drive
    G14 9GD Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    153 Danes Drive
    G14 9GD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishHousewife65155940003
    CALDWELL, David William
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    United KingdomBritishSupply Chain Systems Manager156021830001
    CALDWELL, Gary
    Langford Drive
    G53 7HU Glasgow
    25
    Scotland
    Director
    Langford Drive
    G53 7HU Glasgow
    25
    Scotland
    ScotlandBritishManager237891070001
    CAMERON, Janice Mclean
    Ginza Clockston Road
    KA4 8LP Galston
    Ayrshire
    Director
    Ginza Clockston Road
    KA4 8LP Galston
    Ayrshire
    BritishDirector45656450001
    CARLTON, Blair Nicholas George
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    United KingdomScottishSolicitor155695920001
    CLARK, John Alexander
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    ScotlandBritishRetired156022280001
    CLAY-MACKINNON, Patricia
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishManager217512860001
    CONLON, James Kevin
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    Director
    11 Drumhead Place
    G32 8EY Glasgow
    Fullarton Court, Unit C
    Scotland
    ScotlandBritishRetired185621980001
    COSSAR, Anne Margaret
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    United KingdomBritishOccupational Therapist91853830003
    COWIE, John Mckenzie Grant
    50 Back Road
    FK14 7EA Dollar
    Clackmannanshire
    Director
    50 Back Road
    FK14 7EA Dollar
    Clackmannanshire
    BritishUniversity Professor790800001
    CURRAN, Isaac
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    Director
    Festival Business Centre
    150 Brand Street
    G51 1DH Glasgow
    ScotlandBritishRetired124194320001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SPINAL INJURIES SCOTLAND?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    31 oct 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0