SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED

SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSALON SERVICES FRANCHISING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC092892
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    • Otra venta al por menor en establecimientos no especializados (47190) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE HAIR COMPANY (SCOTLAND) LIMITED18 abr 198518 abr 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    17 páginasAA

    Nombramiento de Ms Heidi Van Ocken como director el 23 mar 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Olivier Badezet como director el 23 mar 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 30 mar 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Warren Peter Scarr como director el 03 feb 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Faulkner como director el 03 feb 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael John Dewey como director el 03 feb 2017

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 13 Queens Road Aberdeen AB15 4YL a 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY el 06 oct 2016

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mark Faulkner el 22 sept 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mark Faulkner el 22 sept 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 mar 2016

    Estado de capital el 16 mar 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nombramiento de Michael John Dewey como director el 07 jul 2015

    3 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 16 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2015

    Estado de capital el 24 mar 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stephen Peckham como director el 10 mar 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard George Hull como director el 09 mar 2015

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AZEMOUDEH, Nina
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secretario
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    British148931840001
    BADEZET, Olivier
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Director
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    FranceFrench245094380001
    SCARR, Warren Peter
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish187830740001
    VAN OCKEN, Heidi
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Director
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    BelgiumBelgian245092140001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Secretario
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    British610080001
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British76739920001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Director
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    ScotlandBritish610080001
    BURNS, Margaret Bell
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Director
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Scotland, UkBritish55852770003
    CONNOLLY, Michael John
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    Director
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117746340001
    DEWEY, Michael John
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    UkAmerican199356850001
    FAULKNER, Mark
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    Director
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    UsaAmerican136766440001
    FINCH, Joanne Sarah
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    HEGARTY, Gerard P
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    Director
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    ScotlandBritish610090002
    HULL, Richard George
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    Director
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish108758410001
    MACDONOUGH, Stephen James
    58 Tiree Place
    Newton Mearns
    G77 6UN Glasgow
    Director
    58 Tiree Place
    Newton Mearns
    G77 6UN Glasgow
    British34759720002
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish76739920001
    PECKHAM, Stephen
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish69764870003
    POSTON, John
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    Director
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    American97966830002
    WINTERHALTER, Gary Gene
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    Director
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    American113530080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Salon Services (Hair & Beauty Supplies) Ltd
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    06 abr 2016
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registroSc049239
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene SALON SERVICES FRANCHISING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 12 abr 1990
    Entregado el 25 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 abr 1990Registro de una carga
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0