GREEN ACTION TRUST

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREEN ACTION TRUST
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa SC093544
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREEN ACTION TRUST?

    • Silvicultura y otras actividades forestales (02100) / Agricultura, silvicultura y pesca

    ¿Dónde se encuentra GREEN ACTION TRUST?

    Dirección de la sede social
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREEN ACTION TRUST?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CENTRAL SCOTLAND GREEN NETWORK TRUST28 mar 201428 mar 2014
    CENTRAL SCOTLAND FOREST TRUST09 sept 200209 sept 2002
    CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST17 dic 199317 dic 1993
    CENTRAL SCOTLAND WOODLANDS: A COUNTRYSIDE TRUST15 abr 199215 abr 1992
    CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST31 may 198531 may 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREEN ACTION TRUST?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2020
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2021
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREEN ACTION TRUST?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    The company (charity no.SC015341) converted into a scio on 19/01/21 14/09/2020
    RES13

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2019

    39 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed central scotland green network trust\certificate issued on 20/07/20
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name20 jul 2020

    Aviso de cambio de nombre

    CONNOT

    Exención de cambio de nombre del uso de "limitada" o "cyfyngedig"

    1 páginasNE01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 jun 2020

    RES15

    Cese del nombramiento de Keith Douglas Wishart como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Edward Lauder como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Malcolm Byers como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Scott Broadley como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Memorándum y Estatutos

    24 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 jun 2020

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Naomi Ruth Arnold como director el 27 mar 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Arthur Asher Keller como director el 06 dic 2019

    1 páginasTM01

    Registro de la carga SC0935440009, creada el 06 sept 2019

    17 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Carron Ann Garmory como director el 19 jun 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2018

    37 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard Scott Broadley como director el 29 mar 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Keith Douglas Wishart como director el 29 mar 2019

    2 páginasAP01

    Memorándum y Estatutos

    27 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de GREEN ACTION TRUST?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KELLY, Christina Sneddon
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Secretario
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    156547580001
    GEDDES, Keith Taylor
    c/o Pagoda Pr
    4
    Eyre Place
    EH3 5JP Edinburgh
    4
    Scotland
    Director
    c/o Pagoda Pr
    4
    Eyre Place
    EH3 5JP Edinburgh
    4
    Scotland
    ScotlandBritish975490004
    LOWTHER, Matthew
    Meridian Court
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Nhs Health Scotland
    Scotland
    Director
    Meridian Court
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Nhs Health Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish196763470001
    PURVES, Karen
    Strand Street
    KA1 1HU Kilmarnock
    East Ayrshire Council
    Scotland
    Director
    Strand Street
    KA1 1HU Kilmarnock
    East Ayrshire Council
    Scotland
    ScotlandBritish234674970001
    TAIT, Stuart
    125 West Regent Street
    Lower Ground Floor
    G2 2SA Glasgow
    Clydeplan
    Scotland
    Director
    125 West Regent Street
    Lower Ground Floor
    G2 2SA Glasgow
    Clydeplan
    Scotland
    ScotlandBritish186422910001
    WARDROP, Martha Ferguson
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Director
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish114206150001
    EDWARDS, Penelope Ann
    Mavisbank Farm Shieldhill Road
    FK1 2AZ Falkirk
    Stirlingshire
    Secretario
    Mavisbank Farm Shieldhill Road
    FK1 2AZ Falkirk
    Stirlingshire
    British57444730001
    GEMMELL, James Campbell, Dr
    Elvang, Queenshuagh
    Riverside
    FK8 1XH Stirling
    Secretario
    Elvang, Queenshuagh
    Riverside
    FK8 1XH Stirling
    British55640360001
    HICKMAN, Elizabeth Linda
    41 Burns Place
    ML7 4LQ Shotts
    Lanarkshire
    Secretario
    41 Burns Place
    ML7 4LQ Shotts
    Lanarkshire
    British752900004
    MACDONALD, Shona Helen
    16 Walnut Drive
    Lenzie
    G66 4BP Glasgow
    Secretario
    16 Walnut Drive
    Lenzie
    G66 4BP Glasgow
    British76263700002
    MILLAR, Jayne
    8 Woodhall Road
    Calderbank
    ML6 9SP Airdrie
    Lanarkshire
    Secretario
    8 Woodhall Road
    Calderbank
    ML6 9SP Airdrie
    Lanarkshire
    British50678460001
    PALMER, John Carrington
    15/2 Brights Crescent
    EH9 2DB Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    15/2 Brights Crescent
    EH9 2DB Edinburgh
    Midlothian
    British66990520001
    YOUNG, Donald
    39 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Secretario
    39 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    British84283580001
    ALCORN, Christopher Michael
    Southfield Gardens West
    Duddingston
    EH15 1RL Edinburgh
    12
    Lothian
    Director
    Southfield Gardens West
    Duddingston
    EH15 1RL Edinburgh
    12
    Lothian
    United KingdomBritish135788150001
    ALDHOUS, John Robert
    12 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    12 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    British142918020001
    ANDERSON, James Fraser Gillan, Councillor
    23 California Road
    Maddiston
    FK2 0NH Falkirk
    Stirlingshire
    Director
    23 California Road
    Maddiston
    FK2 0NH Falkirk
    Stirlingshire
    British1247620001
    ARNOLD, Naomi Ruth
    Prince Edward Street
    G42 8LX Glasgow
    1/1 75 Prince Edward Street
    Scotland
    Director
    Prince Edward Street
    G42 8LX Glasgow
    1/1 75 Prince Edward Street
    Scotland
    ScotlandBritish227961240001
    BECK, Sheila Anne, Dr
    c/o Nhs Health Scotland
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Meridian Court
    Scotland
    Director
    c/o Nhs Health Scotland
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Meridian Court
    Scotland
    ScotlandBritish175621030001
    BELL, Christine
    Croftfoot Place
    FK6 6QT Duncipace
    11
    Stirlingshire
    Director
    Croftfoot Place
    FK6 6QT Duncipace
    11
    Stirlingshire
    United KingdomBritish134169350001
    BOTHAM, Margaret Elizabeth
    22 Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    Director
    22 Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandUnited Kingdom95351570001
    BOWDEN, Lorna
    Flat 2/1 139 Cartvale Road
    G42 9RN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Flat 2/1 139 Cartvale Road
    G42 9RN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102111360001
    BOYLE, William Hannah, Councillor
    28 Kirk Road
    EH48 1BW Bathgate
    West Lothian
    Director
    28 Kirk Road
    EH48 1BW Bathgate
    West Lothian
    ScotlandScottish122333080001
    BRIGGS, Ruth Frances
    8 Camptoun Holdings
    Drem
    EH39 5BA North Berwick
    East Lothian
    Director
    8 Camptoun Holdings
    Drem
    EH39 5BA North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish85919910001
    BROADLEY, Richard Scott
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Director
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish200982870001
    BURNS, Andrew, Councillor
    12 Douglas Place
    ML5 1BY Coatbridge
    Lanarkshire
    Director
    12 Douglas Place
    ML5 1BY Coatbridge
    Lanarkshire
    British42513680001
    BURY, John
    c/o The City Of Edinburgh Council
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    The City Of Edinburgh Council
    Scotland
    Director
    c/o The City Of Edinburgh Council
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    The City Of Edinburgh Council
    Scotland
    ScotlandBritish186793430001
    BYERS, David Malcolm
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Director
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    United KingdomBritish223794130001
    CALDER, Marjorie
    3 Newton Place
    Newton Mearns
    G77 5PG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    3 Newton Place
    Newton Mearns
    G77 5PG Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116418370002
    CAMPBELL, Robert
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    Director
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    British921130001
    COLLINS, Kenneth Darlington, Sir
    11 Stuarton Park
    G74 4LA East Kilbride
    Strathclyde
    Uk
    Director
    11 Stuarton Park
    G74 4LA East Kilbride
    Strathclyde
    Uk
    British51766710001
    CONN, Thomas
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Director
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish167756650001
    CRAWLEY, David Jonathan
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2EH Castle Douglas
    Fleetwood House
    Kirkcudbrightshire
    Director
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2EH Castle Douglas
    Fleetwood House
    Kirkcudbrightshire
    United KingdomBritish120645880003
    CUMMING, Joseph
    12 Loaninghill Park
    Uphall
    EH52 5EB Broxburn
    West Lothian
    Director
    12 Loaninghill Park
    Uphall
    EH52 5EB Broxburn
    West Lothian
    British190480001
    DAVIDSON, Alexander, Councillor
    4 Freeland Terrace
    EH52 5JR Broxburn
    West Lothian
    Director
    4 Freeland Terrace
    EH52 5JR Broxburn
    West Lothian
    British105858680001
    DAVISON, Richard William, Dr
    Redgorton
    PH1 3EW Perth
    Battleby
    Perth & Kinross
    Scotland
    Director
    Redgorton
    PH1 3EW Perth
    Battleby
    Perth & Kinross
    Scotland
    ScotlandBritish139077410001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GREEN ACTION TRUST?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Simon Rennie
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Matthew Lowther
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr John Edward Lauder
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mrs Carron Ann Garmory
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Arthur Asher Keller
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Derek Mccrindle
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr James Ogilivie
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Keith Taylor Geddes
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Peter Macleod Russell
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Ms Marion Mackay Francis
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mrs Linda Gow
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Stuart Tait
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr John Bury
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 jul 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GREEN ACTION TRUST?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    11 jul 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene GREEN ACTION TRUST alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 06 sept 2019
    Entregado el 11 sept 2019
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transacciones
    • 11 sept 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 02 sept 2016
    Entregado el 08 sept 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    Hillhouseridge farm, shottskirk road, shotts. LAN25088.
    Personas con derecho
    • Hartwood Windfarm Limited
    Transacciones
    • 08 sept 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 03 dic 2014
    Entregado el 15 dic 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    All and whole the subjects registered in the land register - title number STG65031.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Kingsburn Wind Energy Limited
    Transacciones
    • 15 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    Standard security
    Creado el 05 nov 2012
    Entregado el 14 nov 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The two areas of land south of the B818 public road at townfoot, title number STG65031.
    Personas con derecho
    • Carron Valley Wind Farm LLP
    Transacciones
    • 14 nov 2012Registro de un cargo (MG01s)
    Floating charge
    Creado el 29 abr 1988
    Entregado el 19 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 19 may 1988Registro de una carga
    • 17 mar 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 07 ene 1988
    Entregado el 11 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 11 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 25 mar 1987
    Entregado el 30 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    158.510 acres or thereby in the parish of shotts and county of lanark (under exception) known as hillhouseridge farm.
    Personas con derecho
    • The Countryside Commission for Scotland
    Transacciones
    • 30 mar 1987Registro de una carga
    • 04 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 31 oct 1986
    Entregado el 19 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 19 nov 1986Registro de una carga
    • 21 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 oct 1986
    Entregado el 09 oct 1986
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The lands and others known as hillhouseridge farm, shotts, lanarkshire under exception.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 09 oct 1986Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0