GREEN ACTION TRUST
Visión general
| Nombre de la empresa | GREEN ACTION TRUST |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Convertida o cerrada |
| Número de empresa | SC093544 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREEN ACTION TRUST?
- Silvicultura y otras actividades forestales (02100) / Agricultura, silvicultura y pesca
¿Dónde se encuentra GREEN ACTION TRUST?
| Dirección de la sede social | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREEN ACTION TRUST?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CENTRAL SCOTLAND GREEN NETWORK TRUST | 28 mar 2014 | 28 mar 2014 |
| CENTRAL SCOTLAND FOREST TRUST | 09 sept 2002 | 09 sept 2002 |
| CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST | 17 dic 1993 | 17 dic 1993 |
| CENTRAL SCOTLAND WOODLANDS: A COUNTRYSIDE TRUST | 15 abr 1992 | 15 abr 1992 |
| CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST | 31 may 1985 | 31 may 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREEN ACTION TRUST?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2020 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2021 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREEN ACTION TRUST?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed central scotland green network trust\certificate issued on 20/07/20 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Exención de cambio de nombre del uso de "limitada" o "cyfyngedig" | 1 páginas | NE01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Keith Douglas Wishart como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Edward Lauder como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Malcolm Byers como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Scott Broadley como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 24 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Naomi Ruth Arnold como director el 27 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Arthur Asher Keller como director el 06 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Registro de la carga SC0935440009, creada el 06 sept 2019 | 17 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carron Ann Garmory como director el 19 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Scott Broadley como director el 29 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Keith Douglas Wishart como director el 29 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GREEN ACTION TRUST?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLY, Christina Sneddon | Secretario | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | 156547580001 | |||||||
| GEDDES, Keith Taylor | Director | c/o Pagoda Pr 4 Eyre Place EH3 5JP Edinburgh 4 Scotland | Scotland | British | 975490004 | |||||
| LOWTHER, Matthew | Director | Meridian Court Cadogan Street G2 6QE Glasgow Nhs Health Scotland Scotland | Scotland | British | 196763470001 | |||||
| PURVES, Karen | Director | Strand Street KA1 1HU Kilmarnock East Ayrshire Council Scotland | Scotland | British | 234674970001 | |||||
| TAIT, Stuart | Director | 125 West Regent Street Lower Ground Floor G2 2SA Glasgow Clydeplan Scotland | Scotland | British | 186422910001 | |||||
| WARDROP, Martha Ferguson | Director | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 114206150001 | |||||
| EDWARDS, Penelope Ann | Secretario | Mavisbank Farm Shieldhill Road FK1 2AZ Falkirk Stirlingshire | British | 57444730001 | ||||||
| GEMMELL, James Campbell, Dr | Secretario | Elvang, Queenshuagh Riverside FK8 1XH Stirling | British | 55640360001 | ||||||
| HICKMAN, Elizabeth Linda | Secretario | 41 Burns Place ML7 4LQ Shotts Lanarkshire | British | 752900004 | ||||||
| MACDONALD, Shona Helen | Secretario | 16 Walnut Drive Lenzie G66 4BP Glasgow | British | 76263700002 | ||||||
| MILLAR, Jayne | Secretario | 8 Woodhall Road Calderbank ML6 9SP Airdrie Lanarkshire | British | 50678460001 | ||||||
| PALMER, John Carrington | Secretario | 15/2 Brights Crescent EH9 2DB Edinburgh Midlothian | British | 66990520001 | ||||||
| YOUNG, Donald | Secretario | 39 Park Place FK7 9JR Stirling | British | 84283580001 | ||||||
| ALCORN, Christopher Michael | Director | Southfield Gardens West Duddingston EH15 1RL Edinburgh 12 Lothian | United Kingdom | British | 135788150001 | |||||
| ALDHOUS, John Robert | Director | 12 Hallhead Road EH16 5QJ Edinburgh Midlothian | British | 142918020001 | ||||||
| ANDERSON, James Fraser Gillan, Councillor | Director | 23 California Road Maddiston FK2 0NH Falkirk Stirlingshire | British | 1247620001 | ||||||
| ARNOLD, Naomi Ruth | Director | Prince Edward Street G42 8LX Glasgow 1/1 75 Prince Edward Street Scotland | Scotland | British | 227961240001 | |||||
| BECK, Sheila Anne, Dr | Director | c/o Nhs Health Scotland Cadogan Street G2 6QE Glasgow Meridian Court Scotland | Scotland | British | 175621030001 | |||||
| BELL, Christine | Director | Croftfoot Place FK6 6QT Duncipace 11 Stirlingshire | United Kingdom | British | 134169350001 | |||||
| BOTHAM, Margaret Elizabeth | Director | 22 Station Road ML8 5AD Carluke Lanarkshire | Scotland | United Kingdom | 95351570001 | |||||
| BOWDEN, Lorna | Director | Flat 2/1 139 Cartvale Road G42 9RN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102111360001 | |||||
| BOYLE, William Hannah, Councillor | Director | 28 Kirk Road EH48 1BW Bathgate West Lothian | Scotland | Scottish | 122333080001 | |||||
| BRIGGS, Ruth Frances | Director | 8 Camptoun Holdings Drem EH39 5BA North Berwick East Lothian | Scotland | British | 85919910001 | |||||
| BROADLEY, Richard Scott | Director | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 200982870001 | |||||
| BURNS, Andrew, Councillor | Director | 12 Douglas Place ML5 1BY Coatbridge Lanarkshire | British | 42513680001 | ||||||
| BURY, John | Director | c/o The City Of Edinburgh Council East Market Street EH8 8BG Edinburgh The City Of Edinburgh Council Scotland | Scotland | British | 186793430001 | |||||
| BYERS, David Malcolm | Director | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | United Kingdom | British | 223794130001 | |||||
| CALDER, Marjorie | Director | 3 Newton Place Newton Mearns G77 5PG Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 116418370002 | |||||
| CAMPBELL, Robert | Director | 128 Strathayr Place KA8 0AY Ayr Ayrshire | British | 921130001 | ||||||
| COLLINS, Kenneth Darlington, Sir | Director | 11 Stuarton Park G74 4LA East Kilbride Strathclyde Uk | British | 51766710001 | ||||||
| CONN, Thomas | Director | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 167756650001 | |||||
| CRAWLEY, David Jonathan | Director | Gatehouse Of Fleet DG7 2EH Castle Douglas Fleetwood House Kirkcudbrightshire | United Kingdom | British | 120645880003 | |||||
| CUMMING, Joseph | Director | 12 Loaninghill Park Uphall EH52 5EB Broxburn West Lothian | British | 190480001 | ||||||
| DAVIDSON, Alexander, Councillor | Director | 4 Freeland Terrace EH52 5JR Broxburn West Lothian | British | 105858680001 | ||||||
| DAVISON, Richard William, Dr | Director | Redgorton PH1 3EW Perth Battleby Perth & Kinross Scotland | Scotland | British | 139077410001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GREEN ACTION TRUST?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Rennie | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Matthew Lowther | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr John Edward Lauder | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Carron Ann Garmory | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Arthur Asher Keller | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Derek Mccrindle | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr James Ogilivie | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Keith Taylor Geddes | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Peter Macleod Russell | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Marion Mackay Francis | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Linda Gow | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Stuart Tait | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr John Bury | 11 jul 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GREEN ACTION TRUST?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 11 jul 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene GREEN ACTION TRUST alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 06 sept 2019 Entregado el 11 sept 2019 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 02 sept 2016 Entregado el 08 sept 2016 | Pendiente | ||
Breve descripción Hillhouseridge farm, shottskirk road, shotts. LAN25088. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 03 dic 2014 Entregado el 15 dic 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción All and whole the subjects registered in the land register - title number STG65031. Contiene una promesa negativa: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 05 nov 2012 Entregado el 14 nov 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The two areas of land south of the B818 public road at townfoot, title number STG65031. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 29 abr 1988 Entregado el 19 may 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 07 ene 1988 Entregado el 11 ene 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 25 mar 1987 Entregado el 30 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 158.510 acres or thereby in the parish of shotts and county of lanark (under exception) known as hillhouseridge farm. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 31 oct 1986 Entregado el 19 nov 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 oct 1986 Entregado el 09 oct 1986 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The lands and others known as hillhouseridge farm, shotts, lanarkshire under exception. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0