CLYDE TECH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLYDE TECH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC095482
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLYDE TECH LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra CLYDE TECH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDE TECH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WALLMASTER TECHNOLOGIES LIMITED 03 feb 199803 feb 1998
    EGLINTON STONE GROUP LIMITED03 ene 198603 ene 1986
    PACIFIC SHELF (SIX) LIMITED10 oct 198510 oct 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDE TECH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDE TECH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de 17 Langside Court Bothwell Lanarkshire G71 8NS el 04 ene 2012

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 08 dic 2011

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 feb 2011

    Estado de capital el 25 feb 2011

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2008

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2007

    10 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2006

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2005

    9 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de CLYDE TECH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHALMERS, Nicholas Oman
    17 Langside Court
    G71 8NS Bothwell
    Lanarkshire
    Secretario
    17 Langside Court
    G71 8NS Bothwell
    Lanarkshire
    British1158020003
    CASTELL, Philip
    Heath Road North
    Locksheath
    SO31 7PP Southampton
    5a
    Hampshire
    Director
    Heath Road North
    Locksheath
    SO31 7PP Southampton
    5a
    Hampshire
    EnglandBritish137475360001
    TIERNEY, Peter
    The Clachan
    Campsie Glen
    G66 7AB Glasgow
    The Cottage, 4
    Director
    The Clachan
    Campsie Glen
    G66 7AB Glasgow
    The Cottage, 4
    ScotlandBritish132283210001
    TWEED, Douglas Mcalister
    1 Dunamoy Road
    Doagh
    BT39 0SZ Ballyclare
    County Antrim
    Secretario
    1 Dunamoy Road
    Doagh
    BT39 0SZ Ballyclare
    County Antrim
    British1128810001
    ALEXANDER, Colin James
    50 Castleton
    Templepatrick
    BT39 0AZ Ballyclare
    County Antrim
    Director
    50 Castleton
    Templepatrick
    BT39 0AZ Ballyclare
    County Antrim
    Northern IrelandBritish143560000001
    BUNTAIN, Christopher
    8 Park Avenue
    PA16 7QX Greenock
    Renfrewshire
    Director
    8 Park Avenue
    PA16 7QX Greenock
    Renfrewshire
    British1331450001
    CHALMERS, Nicholas Oman
    17 Langside Court
    G71 8NS Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    17 Langside Court
    G71 8NS Bothwell
    Lanarkshire
    United KingdomBritish1158020003
    DALY, Richard Henry
    Keralba 3 Gilbert Grove
    FK16 6HX Doune
    Perthshire
    Director
    Keralba 3 Gilbert Grove
    FK16 6HX Doune
    Perthshire
    British498710001
    DALY, Richard Henry
    Keralba 3 Gilbert Grove
    FK16 6HX Doune
    Perthshire
    Director
    Keralba 3 Gilbert Grove
    FK16 6HX Doune
    Perthshire
    British498710001
    GALLACHER, John James
    Wintergreen Drive
    Stewartfield
    G74 4UP East Kilbride
    1
    United Kingdom
    Director
    Wintergreen Drive
    Stewartfield
    G74 4UP East Kilbride
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish134367930001
    HANDLEY, Samuel Kennedy
    1 Crosslee Gardens
    PA6 7AF Houston
    Renfrewshire
    Director
    1 Crosslee Gardens
    PA6 7AF Houston
    Renfrewshire
    ScotlandBritish57610060001
    HODGE, Alan
    8 Chadwell
    SG12 9JX Ware
    Hertfordshire
    Director
    8 Chadwell
    SG12 9JX Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish51358340002
    M'KINSTRY, David
    42 Ballylinney Road
    BT39 9PB Ballyclare
    County Antrim
    Director
    42 Ballylinney Road
    BT39 9PB Ballyclare
    County Antrim
    British1331440001
    MACMILLAN, Arthur Gordon
    Finlaystone
    PA14 6TJ Langbank
    Renfrewshire
    Director
    Finlaystone
    PA14 6TJ Langbank
    Renfrewshire
    ScotlandBritish41842640006
    MACMILLAN, Arthur Gordon
    Finlaystone
    PA14 6TJ Langbank
    Renfrewshire
    Director
    Finlaystone
    PA14 6TJ Langbank
    Renfrewshire
    ScotlandBritish41842640006
    MOORE, John Gordon
    20 Ballater Drive
    Bearsden
    G61 1BY Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    20 Ballater Drive
    Bearsden
    G61 1BY Glasgow
    Lanarkshire
    British516820001
    NELSON, Kenneth John
    60 Chestnut Grove
    ML1 3JF Motherwell
    Lanarkshire
    Director
    60 Chestnut Grove
    ML1 3JF Motherwell
    Lanarkshire
    British5954910001
    O'CONNELL, Peter
    3 Meadowlands
    PO9 2RP Havant
    Hampshire
    Director
    3 Meadowlands
    PO9 2RP Havant
    Hampshire
    American106231520005
    PATERSON, Leonard J
    36 Pelstream Avenue
    FK7 0BE Stirling
    Director
    36 Pelstream Avenue
    FK7 0BE Stirling
    British516810002
    RUNCIE, Geoffrey David
    3 The Fieldings
    KA3 4AU Dunlop
    Ayrshire
    Director
    3 The Fieldings
    KA3 4AU Dunlop
    Ayrshire
    British88779620001
    SMYTH, David Anthony
    Hillside
    1 Village Avenue, Naunton
    GL54 3AS Cheltenham
    Director
    Hillside
    1 Village Avenue, Naunton
    GL54 3AS Cheltenham
    British112002670001
    TWEED, Douglas Mcalister
    1 Dunamoy Road
    Doagh
    BT39 0SZ Ballyclare
    County Antrim
    Director
    1 Dunamoy Road
    Doagh
    BT39 0SZ Ballyclare
    County Antrim
    British1128810001
    WATSON, Robert Kilpatrick
    Holmlees East Greenlees Road
    Cambuslang
    G72 8TH Glasgow
    Director
    Holmlees East Greenlees Road
    Cambuslang
    G72 8TH Glasgow
    British49621980001

    ¿Tiene CLYDE TECH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 04 jun 1999
    Entregado el 23 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Vector Engineering Products Limited
    Transacciones
    • 23 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 31 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 04 jun 1999
    Entregado el 23 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal charge over property; various fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Vector Engineering Products Limited
    Transacciones
    • 23 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 31 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 04 jun 1999
    Entregado el 11 jun 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 17 jun 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 04 jun 1999
    Entregado el 11 jun 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 17 jun 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Mortgage
    Creado el 08 dic 1988
    Entregado el 23 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The white house number one, the green feltham, london.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 23 dic 1988Registro de una carga
    • 06 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene CLYDE TECH LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 ago 2012Fecha de disolución
    08 dic 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0