PREMIER BRANDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PREMIER BRANDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC096055 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PREMIER BRANDS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PREMIER BRANDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | First Floor 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREMIER BRANDS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DMWS 24 LIMITED | 20 nov 1985 | 20 nov 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PREMIER BRANDS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PREMIER BRANDS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREMIER BRANDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 mar 2025 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Duncan Neil Leggett el 30 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2024 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 abr 2023 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Summit House 4 - 5 Mitchell Street Edinburgh Scotland EH6 7BD a First Floor 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 15 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 abr 2022 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Premier Foods (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 feb 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Premier Financing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 feb 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Estado de capital el 14 dic 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 dic 2021
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 13 dic 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 abr 2021 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Notification de Premier Financing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 ago 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Premier Financing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 ago 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PREMIER BRANDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh First Floor Scotland | British | 125719290002 | ||||||
| LEGGETT, Duncan Neil | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh First Floor Scotland | United Kingdom | British | 299645890002 | |||||
| ROSE, Simon Alan | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh First Floor Scotland | England | British | 105238100003 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh First Floor Scotland | England | British | 125719290002 | |||||
| HINES, Christine Anne | Secretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| SHEWARD, Philip Charles | Secretario | Pippins 23 Twatling Road Barnt Green B45 8HY Birmingham West Midlands | British | 49813130001 | ||||||
| BOWEN, Charles John | Director | Isington Mill GU34 4PW Alton Hants | British | 801170002 | ||||||
| BRALSFORD, David Martin | Director | The Paddocks 21 Plymouth Road Barnt Green B45 8JF Birmingham West Midlands | British | 51072880001 | ||||||
| BRODIE, William David | Director | 5 Silver Birch Drive Hollywood B47 5RB Birmingham West Midlands | British | 31967280001 | ||||||
| BROWN, Joseph Arthur | Director | 15 Hayward Road OX2 8LN Oxford Oxfordshire | British | 27217550001 | ||||||
| CADBURY, Roger Victor John | Director | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | 2189460001 | |||||
| CAMPBELL, Rosalind Ilona | Director | 6 Hawthorn Close WD17 4SB Watford Hertfordshire | British | 58191970001 | ||||||
| CONSTANDSE, Bart Jan | Director | Schimmelpennincklaan 2 Eindhoven FOREIGN Netherlands 5631 An | Dutch | 65256850003 | ||||||
| HAMILTON, Bruce Ian | Director | Deebank House High Street Farndon CH3 6PU Chester Cheshire | British | 56604580001 | ||||||
| HANCOX, Michael John | Director | Sweet Briar Hall Gallows Clough Lane Oakmere CW8 2TG Northwich Cheshire | British | 109509510001 | ||||||
| HEPBURN, Jim | Director | Centrium Business Park, Griffiths Way AL1 2RE St. Albans Premier Foods, Premier House England And Wales United Kingdom | Scotland | Scottish | 162125080001 | |||||
| HINES, Christine Anne | Director | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| JUDGE, Paul Rupert, Sir | Director | Grange Farm Elmbridge WR9 0DA Droitwich Worcestershire | British | 33015750002 | ||||||
| LAND, Sian Louise | Director | 11 Clover Drive Pickmere WA16 0WF Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 86278210001 | |||||
| LEACH, Paul Alan | Director | Griffiths Way AL1 2RE St. Albans Premier House, Centrium Business Park Hertfordshire | United Kingdom | British | 136797430001 | |||||
| LEACH, Paul Alan | Director | 20 Malvern Road SL6 7RH Maidenhead Berkshire | British | 60788330001 | ||||||
| LILLINGTON, Keith William | Director | The Old Bowling Green Broad Lane Moulton Chapel PE12 6PN Spalding Lincolnshire | British | 803140001 | ||||||
| LYONS, Colim Fionbar | Director | 14 Carrickbrack Heath Sutton IRISH Dublin | British | 32152010001 | ||||||
| MACKEE, Stephen Patrick | Director | 101 Gayton Road PE30 4EW Kings Lynn Norfolk | United Kingdom | British | 29126720002 | |||||
| MATON, John Charles | Director | Stour View House Wick Lane BH23 1HU Christchurch Dorset | British | 64748810003 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Director | 4 - 5 Mitchell Street EH6 7BD Edinburgh Summit House Scotland | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCPHERSON, Kasey | Director | 4 - 5 Mitchell Street EH6 7BD Edinburgh Summit House Scotland | United Kingdom | New Zealander | 246893430001 | |||||
| MOTTRAM, Robert John | Director | The Round House Croft Drive CH48 2JN Caldy Merseyside | England | British | 466220001 | |||||
| NEWTON, David Alexander | Director | Falcon House Mellis IP23 8DQ Eye Suffolk | British | 108260001 | ||||||
| NICHOLS, John Ellis | Director | 353 Hills Road CB2 2QT Cambridge Cambridgeshire | British | 7351450001 | ||||||
| O'NEILL, Anthony Christopher | Director | 1 Ballyhannon Lane Portadown BT63 5YF County Armagh Northern Ireland | Northern Ireland | British | 146393340001 | |||||
| ORCHARD, Stephen William | Director | The Orchards Meadow Lane Houghton PE17 2BP Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 36964770001 | |||||
| PEELER, Andrew Michael | Director | Griffiths Way AL1 2RE St. Albans Premier House, Centrium Business Park Hertfordshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| PERKINS, John Albert | Director | The Old Rectory Great Comberton WR10 3DP Pershore Worcestershire | British | 89897640001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PREMIER BRANDS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Foods (Holdings) Limited | 11 feb 2022 | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Premier Financing Limited | 17 ago 2021 | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Hsbc Corporate Trustee Company (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Canada Square E14 5HQ London 8 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Premier Financing Limited | 06 abr 2016 | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St. Albans Premier House Hertfordshire England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0