IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC096145 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
| Dirección de la sede social | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STORTEXT LIMITED | 14 ago 1998 | 14 ago 1998 |
| STORTEXT (SCOTLAND) LIMITED | 27 nov 1985 | 27 nov 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 ene 2011
| 7 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Subdivisión de acciones el 09 dic 2010 | 5 páginas | SH02 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 oct 2010 au 31 dic 2010 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2009 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 22 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Paul Golesworthy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Golesworth como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Christopher David George Thomas el 19 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Paul Golesworth como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Eglinton el 19 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Roderick Day el 19 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Marc Duale como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS, Christopher David George | Secretario | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston | British | 136331200001 | ||||||
| DAY, Roderick | Director | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston | United Kingdom | British | 132997840001 | |||||
| EGLINTON, Peter Damian | Director | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston | United Kingdom | British | 137660810001 | |||||
| GOLESWORTHY, Simon Paul | Director | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston | England | British | 126710690002 | |||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Secretario | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | British | 45345090004 | ||||||
| FORDHAM, Andrew | Secretario | The Granary Bears Hay Farm Brookhay Lane WS13 8RG Lichfield Staffordshire | British | 110434940001 | ||||||
| HODGSON, Richard | Secretario | 3 Willow Avenue Barnes SW13 0LT London | British | 96788660001 | ||||||
| HOUSTON, Mark Ian | Secretario | St Fillans Cottage 2a St Fillans Terrace EH10 5NH Edinburgh | British | 266330001 | ||||||
| LYON, Joseph | Secretario | 34 The Uplands SL9 7JG Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 57811150001 | ||||||
| MCCULLOCH, Colin John | Secretario | Seaforth Cottage 29 York Road EH5 3EG Edinburgh Midlothian | British | 75795920001 | ||||||
| RADTKE, Kenneth | Secretario | 12b Thorney Court Apartments Palace Gate W8 5NL London | American | 96788410001 | ||||||
| WALLACE, Graham Alexander Drummond | Secretario | Brewlands Lodge 22 Newmills Road EH22 2AH Dalkeith Midlothian | British | 70304160001 | ||||||
| CAMPBELL, Thomas Walter | Director | Warwick Gardens Kensington W14 8PH London 13 England | American | 106922290002 | ||||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Director | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | England | British | 45345090004 | |||||
| DUALE, Marc | Director | 6 Bentinck Mansions 12-16 Bentinck Street W1U 2ER London | French | 121593810001 | ||||||
| GOLESWORTHY, Simon Paul | Director | Whitelaw House Alderstone House Business Park EH54 7AW Livingston | England | British | 126710690002 | |||||
| HODGSON, Richard | Director | 3 Willow Avenue Barnes SW13 0LT London | British | 96788660001 | ||||||
| HOUSTON, Mark Ian | Director | St Fillans Cottage 2a St Fillans Terrace EH10 5NH Edinburgh | British | 266330001 | ||||||
| LITTLE, John Noel | Director | Dunosdale 22 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | 848240001 | ||||||
| MAKOWSKI, Richard | Director | Hollisters Combe Bottom Shere GU5 9TD Guildford Surrey | United Kingdom | British | 125161430001 | |||||
| MCCULLOCH, Colin John | Director | Seaforth Cottage 29 York Road EH5 3EG Edinburgh Midlothian | British | 75795920001 | ||||||
| ORR, James Alexander Macconnell | Director | 10 Learmonth Grove EH4 1BP Edinburgh | Scotland | British | 81233650001 | |||||
| PAUL, Douglas Bruce | Director | 7 Cotlands Avenue EH32 0QU Longniddry East Lothian | British | 28198030002 | ||||||
| PRICE, Phillip John | Director | Broadway House Chartridge HP5 2TT Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 119570600001 | |||||
| PROWSE, John | Director | 317 Ongar Road CM15 9HP Brentwood Essex | England | British | 96786510001 | |||||
| RADTKE, Kenneth | Director | 12b Thorney Court Apartments Palace Gate W8 5NL London | American | 96788410001 | ||||||
| RITCHIE, William Martin | Director | Keston 4 Buckstane Park EH10 6PA Edinburgh | Scotland | British | 36556530001 | |||||
| SCOTT, Graeme John | Director | 11 Dean Terrace EH4 1ND Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 101636440001 | |||||
| SMITH, Nicholas Paul | Director | Scrag Oak TN5 6NP Wadhurst Sussex | United Knigdom | British | 32981540001 | |||||
| WALLACE, Graham Alexander Drummond | Director | Brewlands Lodge 22 Newmills Road EH22 2AH Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 70304160001 |
¿Tiene IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 11 abr 1995 Entregado el 25 abr 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 1) 2.634 acres on the west side of traquair road, peebles-shire 2) 1.536 acres on the east side of traquair road, peebles-shire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 sept 1994 Entregado el 23 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Interest in the lease granted by the forth ports authority in favour of bents properties limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 07 oct 1991 Entregado el 09 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Property k/a 58 west harbour road granton edinburgh otherwise k/a 25 sealcarr st. Edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 19 sept 1991 Entregado el 26 sept 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 30 nov 1990 Entregado el 07 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 29 sept 1989 Entregado el 11 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 13 ene 1986 Entregado el 22 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0