MACRAE EDINBURGH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MACRAE EDINBURGH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC096174 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MACRAE EDINBURGH LIMITED?
- Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Dirección de la sede social | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GHILLIE & GLEN LIMITED | 29 nov 1985 | 29 nov 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS el 14 may 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA a C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 17 jul 2020 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 23 mar 2020
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jenny Nancy Loncaster como director el 25 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Mark Busby como director el 12 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont como director el 04 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited como secretario el 04 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd el 19 nov 2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Mark Busby como director el 31 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Herbert Lofts como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Director | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| GAULT, Sandra | Secretario | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| MACDONALD, Bruce Dey | Secretario | C/O 91 Blenheim Place Aberdeen | British | 238040002 | ||||||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secretario corporativo | 1 Golden Square AB10 1HA Aberdeen | 73896680007 | |||||||||||
| STRONACHS | Secretario corporativo | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Director | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | 71513420001 | ||||||||||
| BAIN, John | Director | Braikley Park Tarves AB41 0NJ Ellon Aberdeenshire | British | 437860001 | ||||||||||
| BERRY, Lesley Ann | Director | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | 26040480001 | ||||||||||
| BERRY, Richard George | Director | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | 238050003 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Director | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| CROAN, John | Director | Hadlea 13 East Lillypot EH5 3BH Edinburgh | British | 72018570003 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Roy Macgregor | Director | 19 Keith Avenue Balmedie AB23 8ZR Aberdeen | Scottish | 61174780001 | ||||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| GALBRAITH, James Leathley | Director | 3 Berrywell Road Dyce AB2 0DA Aberdeen Aberdeenshire | British | 238070001 | ||||||||||
| HARKJAER, Per | Director | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HAZELDEAN, James William | Director | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 10359650007 | |||||||||
| KNUTTON, Roderick Leonard | Director | Loanhead Of Pitinnan Daviot AB51 0JH Inverurie Aberdeenshire | British | 35167880001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Director | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LITTLE, Hugh Wilson Mcintosh | Director | 22 Kirk Crescent North Cults AB1 9RP Aberdeen | British | 679520002 | ||||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 185293570001 | |||||||||
| MCLELLAND, Stewart | Director | 34 Camperdown Road AB15 5NU Aberdeen | British | 61174880001 | ||||||||||
| PARKER, Michael | Director | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| PORTEOUS, Ronald | Director | Coirseunan Lodge Whitecairns AB23 8UN Aberdeen | British | 42171410001 | ||||||||||
| WARD, George Murray | Director | 14 Ballaig Avenue Bearsden G61 4HA Glasgow Lanarkshire | British | 238080001 | ||||||||||
| WHALEN, John | Director | 28 Argyle Terrace FK15 9DN Dunblane Perthshire | British | 70788960005 | ||||||||||
| WILKINS, Lesley Ann | Director | 32 Airyhall Crescent AB1 7QT Aberdeen Aberdeenshire | British | 238060001 | ||||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Director | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 | |||||||||
| TENON NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 10 Queens Terrace AB10 1YG Aberdeen | 52499670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MACRAE EDINBURGH LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06 abr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MACRAE EDINBURGH LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 06 nov 2008 Entregado el 20 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Tenants interest in lease of subjects known as unit 1, starlaw park, livingston WLN40990. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 oct 2008 Entregado el 05 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 sept 2008 Entregado el 03 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 mar 2007 Entregado el 31 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 mar 2006 Entregado el 29 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 12 dic 2005 Entregado el 20 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 29 jul 2004 Entregado el 09 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over all material premises; fixed charge over assets; floating charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 ago 2000 Entregado el 15 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 ago 2000 Entregado el 15 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 16 dic 1992 Entregado el 31 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 16 dic 1992 Entregado el 31 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 19 oct 1989 Entregado el 27 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 21 sept 1989 Entregado el 03 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 02 jul 1988 Entregado el 21 jul 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The foster blast freezer, bqf 100-600 with serial number 193593. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 02 jul 1988 Entregado el 21 jul 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 12 feb 1988 Entregado el 29 feb 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
¿Tiene MACRAE EDINBURGH LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0