ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC096855 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower 77 Renfrew Street G2 3BZ Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 jul 2018 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 abr 2019 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2017 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 nov 2019 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 09 dic 2019 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 nov 2018 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden judicial Order of court - dissolution void | 1 páginas | OC-DV | ||||||||||
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en CVL | 21 páginas | LIQ14(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ a 11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G2 3BZ el 30 sept 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD a 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ el 07 jun 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Melville Street Edinburgh EH3 7HF Scotland a 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD el 01 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carol Dora Brodie como director el 25 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Trevor Reid como director el 25 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Alexander Mckinney como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graeme Leslie Hadden como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Bruce Dickson como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick Robertson Gammell como director el 25 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Jane Spurgeon Grotrian como director el 02 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graeme Leslie Hadden como director el 02 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Sarah Jane Spurgeon Grotrian como director el 15 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Dr Peter Trevor Reid como director el 15 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 jul 2017 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Bruce Dickson como director el 15 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Arthur Conway como director el 15 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Woodcock como director el 01 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham John Thomson Forbes como director el 15 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFCOAT, David Charles Elessing | Secretario | Clockwise Offices, Savoy Tower 77 Renfrew Street G2 3BZ Glasgow 11th Floor, Room 1110 | 238863640001 | |||||||
| CONWAY, John Arthur, The Very Reverend | Director | Lansdowne Crescent EH12 5EQ Edinburgh 8 Scotland | Scotland | British | 239459530001 | |||||
| WOODCOCK, Neil | Director | Lennox Row EH5 3HL Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 1198420001 | |||||
| BEBER, Sheila Hemingway | Secretario | 12 Buckingham Terrace EH4 3AA Edinburgh Midlothian | British | 56580001 | ||||||
| BRUCE, Alexander James Arbuthnot | Secretario | 4 Great Stuart Street EH3 6AW Edinburgh | British | 1286720002 | ||||||
| JEFFCOAT, Marilyn Annette | Secretario | Mill Wynd KY15 7BU Falkland Stag House Fife United Kingdom | British | 63483550003 | ||||||
| BARBER, Joe Millar | Director | Bridgelands TD7 4PT Selkirk | British | 781870001 | ||||||
| BRODIE, Carol Dora, Lady | Director | Cobden Crescent EH9 2BG Edinburgh 21 | United Kingdom | British | 133066050001 | |||||
| BRUCE, Mary Hope | Director | 4 Great Stuart Street EH3 6AW Edinburgh Midlothian | British | 56640001 | ||||||
| CROSFIELD, George Philip Chorley | Director | 8 Lansdowne Crescent EH12 5EQ Edinburgh Midlothian | British | 132990001 | ||||||
| DICKSON, David Bruce | Director | Millbank EH17 7GA Balerno 13 Scotland | Scotland | British | 215033080001 | |||||
| FORBES, Donald James | Director | 33 Coates Gardens EH12 5LG Edinburgh Midlothian | British | 56600001 | ||||||
| FORBES, Graham John Thomson, The Very Reverend Dr | Director | 8 Lansdowne Crescent EH12 5EQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37943660001 | |||||
| GAMMELL, Patrick Robertson | Director | The Old Manse Morham EH41 4LQ Haddington East Lothian | Scotland | British | 285170001 | |||||
| GROTRIAN, Sara Jane Spurgeon | Director | Castleview Hawthornden EH18 1EJ Lasswade Midlothian | British | 125519150001 | ||||||
| GROTRIAN, Sarah Jane Spurgeon | Director | Hawthornden EH18 1EJ Lasswade Castleview Scotland | Scotland | British | 128914330001 | |||||
| GUILD, Ivor Reginald | Director | The New Club 86 Princes Street EH2 2BB Edinburgh | United Kingdom | British | 41504740001 | |||||
| HADDEN, Graeme Leslie | Director | Melville Street EH3 7HF Edinburgh 50 Scotland | Scotland | British | 222881990001 | |||||
| JEFFCOAT, Marilyn Annette | Director | Mill Wynd KY15 7BU Falkland Stag House Fife | Scotland | British | 63483550005 | |||||
| MARKS, Frederick Charles | Director | Dunkeld 33 Townhill Road KY12 0JD Dunfermline Fife | British | 135790001 | ||||||
| MCKINLAY, Peter, Cbe | Director | Braemoray 11 Alexander Third Street HY3 9SD Kinghorn Fife | British | 60892980001 | ||||||
| MCKINNEY, John Alexander | Director | Edderston Ridge EH45 9NA Peebles 9 Scotland | Scotland | British | 118061190002 | |||||
| REID, Peter Trevor, Dr | Director | Cumin Place EH9 2JX Edinburgh 19 Scotland | Scotland | British | 166999500002 | |||||
| TUDOR, James Brian | Director | 15 Midmar Gardens EH10 6DY Edinburgh Midlothian | Great Britain | British | 56630001 | |||||
| WALKER, William Alexander | Director | 40 Cherry Tree Gardens EH14 5SP Balerno Midlothian | British | 56610001 | ||||||
| YOUNG, David Tod | Director | 4 High Street Auchtermuchty KY14 7AT Cupar Fife | British | 56650001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 25 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0