CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC096918 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 60 Melville Street EH3 7HF Edinburgh Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ERNST & YOUNG FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED | 12 sept 1989 | 12 sept 1989 |
| ARTHUR YOUNG FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED | 21 mar 1986 | 21 mar 1986 |
| PACIFIC SHELF (FIFTEEN) LIMITED | 22 ene 1986 | 22 ene 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2025 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Miss Jessica Abigail May Lewis el 13 nov 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Rees Thomas como director el 10 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de Trinitybridge Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 abr 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Modification des détails de Close Asset Management Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 abr 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 jul 2025 au 31 mar 2025 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2024 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2023 | 8 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Edmeads como director el 17 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Iain Paul Wallace como director el 17 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Miss Jessica Abigail May Lewis el 23 ago 2023 | 1 páginas | CH03 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh Scotland EH1 2EN Scotland a 60 Melville Street Edinburgh Scotland EH3 7HF el 29 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2022 | 8 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 4th Floor - the Athenaeum Building 8 Nelson Mandela Place Glasgow G2 1BT United Kingdom a 3rd Floor Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh Scotland EH1 2EN el 18 oct 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mrs Catherine Jane Parry como director el 04 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Andrew como director el 04 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2021 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Martin Andrew como director el 20 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew William Cumming como director el 20 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2020 | 5 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Jessica Abigail May | Secretario | Melville Street EH3 7HF Edinburgh 60 Scotland Scotland | 162482360002 | |||||||
| EDMEADS, John | Director | Melville Street EH3 7HF Edinburgh 60 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 287730220001 | |||||
| PARRY, Catherine Jane | Director | Melville Street EH3 7HF Edinburgh 60 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 185247500001 | |||||
| THOMAS, Andrew Rees | Director | Melville Street EH3 7HF Edinburgh 60 Scotland Scotland | England | British | 178516480001 | |||||
| FRANKLIN, Tim | Secretario | George House 50 George Square G2 1RR Glasgow Lanarkshire | British | 62072100001 | ||||||
| HENSON, Ian Robert | Secretario | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | British | 134091530001 | ||||||
| KELLY, Jeffrey Gordon | Secretario | George House 50 George Square G2 1RR Glasgow Lanarkshire | British | 59920001 | ||||||
| MCMENEMY, Peter | Secretario | 14 Braeside Avenue G62 6LH Milngavie Glasgow | British | 41227480001 | ||||||
| PROVAN, Alexander Shaw | Secretario | 113 Ochiltree FK15 0PA Dunblane Perthshire | British | 45071690001 | ||||||
| RUSSELL, Thomas Moore | Secretario | 26 Boghead Road Lenzie G66 4EE Glasgow Lanarkshire | British | 85592750001 | ||||||
| ANDREW, Martin | Director | 8 Nelson Mandela Place G2 1BT Glasgow 4th Floor - The Athenaeum Building United Kingdom | United Kingdom | British | 84997270001 | |||||
| BARTON, Alan John | Director | 141 Alwoodley Lane LS17 7PG Leeds West Yorkshire | British | 65451860002 | ||||||
| BIRCH, Trevor Nigel | Director | 22 Delamere Road Adusdale PR8 2RD Southport Merseyside | British | 41398400002 | ||||||
| CHAMBERS, Paul Stuart | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 172496620001 | |||||
| CLARKE, Gillian Marjorie | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | England | British | 154546630001 | |||||
| CUMMING, Andrew William | Director | 10 Crown Place EC2A 4FT London Close Brothers Group Plc United Kingdom | Scotland | British | 60118800004 | |||||
| CURRY, Richard Ian | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 105013710002 | |||||
| DAVIS, Edward Becton | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | England | American | 167180370002 | |||||
| DAVIS, Michael Ian | Director | Hurlstone House 8 Bentinck Road WA14 2BP Altrincham Cheshire | England | British | 14192220001 | |||||
| FAIRBAIRN, Douglas Mackay | Director | George House 50 George Square G2 1RR Glasgow Lanarkshire | British | 78265300001 | ||||||
| FAY, Andrew Steven | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 194736380001 | |||||
| FINLAYSON, Robert William | Director | 17 Abercromby Place EH3 6LT Edinburgh Midlothian | British | 994010002 | ||||||
| GAWN, Angus Duncan | Director | 26 Burness Avenue Alloway KA7 4QB Ayr Ayrshire | British | 27207990001 | ||||||
| GEUREE, Michael David | Director | Rolls House 7 Rolls Building EC4A 1NL London | British | 59960001 | ||||||
| GILLESPIE, Charles | Director | 11 Garrick Avenue Mearnskirk G77 5GF Newton Mearns Glasgow | Uk/Scotland | British | 85654910001 | |||||
| GORMAN, Joseph | Director | 4 Ardfern Road ML6 8NN Airdrie Lanarkshire | British | 77554810002 | ||||||
| HALDANE, James Martin | Director | 17 Abercromby Place EH3 6LB Edinburgh Midlothian | British | 745050001 | ||||||
| HEATH, David John | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 254412870001 | |||||
| HENSON, Ian Robert | Director | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | England | British | 134091530001 | |||||
| KELLY, Jeffrey Gordon | Director | George House 50 George Square G2 1RR Glasgow Lanarkshire | British | 59920001 | ||||||
| KHNICHICH, Margaret Elizabeth | Director | 70 Bellshaugh Gardens G12 0SA Glasgow | British | 50910890001 | ||||||
| LAING, Stephen George | Director | 27 Ashburton Road CH43 8TN Prenton Merseyside | United Kingdom | British | 24914370001 | |||||
| LAND, Nicholas Charles Edward | Director | George House 50 George Square G2 1RR Glasgow | British | 1079550002 | ||||||
| LEARY, Trevor Aandrew Falcon | Director | Hilbre House Macdona Drive L48 3JD Wirral Merseyside | British | 41398170001 | ||||||
| LUCKETT, Philip Lawrence | Director | Netherby 1 Hall Road SK9 5BW Wilmslow Cheshire | England | British | 102989430001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CAVANAGH FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinitybridge Holdings Limited | 13 abr 2016 | 42 Wigmore Street W1U 2RY London Wigmore Yard England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0