AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED

AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC097757
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    • (6712) /

    ¿Dónde se encuentra AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WEST GEORGE STREET (317)10 mar 198610 mar 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    5 páginas4.26(Scot)

    Resolución de insolvencia

    Resolution INSOLVENCY:Joint liquidators' statement of account approved
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 oct 2011

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de 191 West George Street Glasgow G2 2LD el 11 nov 2011

    2 páginasAD01

    legacy

    4 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    Nombramiento de Femi Sobo-Allen como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jeffrey Lader como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2010

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 mar 2011

    Estado de capital el 16 mar 2011

    • Capital: GBP 9,717,500
    SH01

    Nombramiento de Paul Charles Whitehead como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Angus Rigby como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2009

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Angus Michael Rigby el 09 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Jeffrey Lader el 09 mar 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Caroline Jane Bradley el 09 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 oct 2008

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 oct 2007

    9 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SOBO-ALLEN, Femi
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Secretario
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    161588210001
    BRADLEY, Caroline Jane
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Director
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    United KingdomBritish279883630001
    WHITEHEAD, Paul Charles
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Director
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    UkDual Nationality Canadian/American154025550001
    BRADLEY, Caroline Jane
    24 Lakeside View
    Rawdon
    LS19 6RN Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    24 Lakeside View
    Rawdon
    LS19 6RN Leeds
    West Yorkshire
    British60987050001
    CORNYN, John
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    Secretario
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    British584620001
    LADER, Jeffrey
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LD
    Secretario
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LD
    British91785040001
    LEITH, Daniel
    406 Elm Tree Court
    Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Secretario
    406 Elm Tree Court
    Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    British49922240002
    MCKENZIE, Helen Marie
    2 Seafield Court
    FK1 5JZ Falkirk
    Stirlingshire
    Secretario
    2 Seafield Court
    FK1 5JZ Falkirk
    Stirlingshire
    British68683150002
    MCSPORRAN, Archibald Campbell
    18 Broomlands Crescent
    PA8 7BN Erskine
    Renfrewshire
    Secretario
    18 Broomlands Crescent
    PA8 7BN Erskine
    Renfrewshire
    British1367200001
    MITCHELL, Fiona
    11 Charles Drive
    FK5 3HB Larbert
    Stirlingshire
    Secretario
    11 Charles Drive
    FK5 3HB Larbert
    Stirlingshire
    British68683100001
    NIKLAS, Elizabeth
    22 The Nautilus Building
    3 Myddelton Passage
    EC1R 1XW London
    Secretario
    22 The Nautilus Building
    3 Myddelton Passage
    EC1R 1XW London
    British76189520003
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    British39851670003
    STEADMAN, Valentine Germaine Cecile
    11 Titmore Green
    Little Wymondley
    SG4 7JT Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    11 Titmore Green
    Little Wymondley
    SG4 7JT Hitchin
    Hertfordshire
    British81906140001
    SULLIVAN, Terence Michael
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    Secretario
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    British11433910001
    TRANTOR, Colin Grant
    25 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    Secretario
    25 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    British52881000001
    VARDY, Richard John
    Court Cottage
    Headley Road
    GU26 6DL Grayshott
    Surrey
    Secretario
    Court Cottage
    Headley Road
    GU26 6DL Grayshott
    Surrey
    British153085180001
    WOOD, David Roy
    6 Old School Field
    Springfield Green
    CM1 7HU Chelmsford
    Essex
    Secretario
    6 Old School Field
    Springfield Green
    CM1 7HU Chelmsford
    Essex
    British53910300001
    ANDERSON, Andrew John
    19 Chishill Road
    Heydon
    SG8 8PW Royston
    Hertfordshire
    Director
    19 Chishill Road
    Heydon
    SG8 8PW Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish33765840001
    BARCLAY, James Christopher
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    Director
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish6395690001
    BARRA, Joseph Nicholas
    19 Corwin Court
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    Director
    19 Corwin Court
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    American77192110001
    BAYS, Rochelle
    26 St. James's Place
    SW1A 1NH London
    Director
    26 St. James's Place
    SW1A 1NH London
    American78861810001
    BOWES-LYON, David James
    Heriot Water
    EH38 5YE Heriot
    Midlothian
    Director
    Heriot Water
    EH38 5YE Heriot
    Midlothian
    ScotlandBritish50820001
    CARMICHAEL, William
    1 Glamis Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SQ Auchterarder
    Perthshire
    Director
    1 Glamis Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SQ Auchterarder
    Perthshire
    British105075920001
    CORNYN, John
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    Director
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    British584620001
    COSSEY, Geoffrey William
    Weston House
    Tillington
    GU28 0RA Petworth
    West Sussex
    Director
    Weston House
    Tillington
    GU28 0RA Petworth
    West Sussex
    British37377430003
    DOWD, Kenneth Leslie
    1 Century Building Saint Marys
    Parsonage
    M3 2DD Manchester
    Director
    1 Century Building Saint Marys
    Parsonage
    M3 2DD Manchester
    Canadian74603280001
    DUVAR, Jeff
    Flat 1 Ifield Road
    SW10 9AD London
    Director
    Flat 1 Ifield Road
    SW10 9AD London
    Canadian78865510001
    FOULKES, Michael Alexander
    466a Shadwell Lane
    LS17 8BA Leeds
    West Yorkshire
    Director
    466a Shadwell Lane
    LS17 8BA Leeds
    West Yorkshire
    Canadian99246240002
    GARDNER, John Thomas
    Little Copthall Kings Lane
    Chipperfield
    WD4 9EN Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    Little Copthall Kings Lane
    Chipperfield
    WD4 9EN Kings Langley
    Hertfordshire
    American72893410001
    GILCHRIST, Graeme Elder, Col (Retired)
    50 Holmbush Road
    Putney
    SW15 3LE London
    Director
    50 Holmbush Road
    Putney
    SW15 3LE London
    EnglandBritish584650001
    GORMAN, Lon
    24 Sherwood Downs
    FOREIGN Park Ridge
    New Jersey 07656
    Usa
    Director
    24 Sherwood Downs
    FOREIGN Park Ridge
    New Jersey 07656
    Usa
    American76871250001
    HOPTON, David
    6 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    6 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish6395670001
    LEONARD, James Patrick
    104 Canoe Brook Lane
    07931 Far Hills
    New Jersey
    America
    Director
    104 Canoe Brook Lane
    07931 Far Hills
    New Jersey
    America
    American76387820001
    MARTIN, Ian James
    Domaine De Peyloubere
    32550 Pavie
    France
    Director
    Domaine De Peyloubere
    32550 Pavie
    France
    British33782910001
    MASRANI, Bharat Bhagwanzi
    Flat 6
    2 Avenue Road
    NW8 7PU London
    Director
    Flat 6
    2 Avenue Road
    NW8 7PU London
    British65691240002

    ¿Tiene AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 20 nov 2001
    Entregado el 29 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due in connection with the facility agreement
    Breve descripción
    Fixed charge over all sums and payments relating to any stocks in crest; all right title and interest in the money standing to the credit of the controlled accounts; all right(including property rights) title and interest in all securities held in each escrow account ; floating charge over all eligible stock held by the company in crest; all property rights or intesrt in crest; all sums and benefits becoming due by reason of the entitlement to stock in crest...see microfiche for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 nov 2001Registro de un cargo (410)
    • 01 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 14 feb 1997
    Entregado el 25 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All stock or property etc.... see the mortgage charge document for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 25 feb 1997Registro de un cargo (410)
    • 01 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 14 feb 1997
    Entregado el 18 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All eligble stock etc.... see the mortgage charge document for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1997Registro de un cargo (410)
    • 12 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 16 dic 1996
    Entregado el 24 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1996Registro de un cargo (410)
    • 12 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of set-off
    Creado el 29 dic 1986
    Entregado el 06 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descripción
    All sums standing at the credit of the company with the bank on current account.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 ene 1987Registro de una carga
    • 14 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Charge
    Creado el 29 sept 1986
    Entregado el 13 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The beneficial interest of the company under a general trust deed 1.
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland
    Transacciones
    • 13 oct 1986Registro de una carga
    • 18 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    General charge
    Creado el 10 jun 1986
    Entregado el 24 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Beneficial interest of the company under a general trust deed.
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange
    Transacciones
    • 24 jun 1986Registro de una carga
    • 18 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)

    ¿Tiene AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 ene 2013Fecha de disolución
    31 oct 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0