SKELLY'S LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SKELLY'S LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC105552 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SKELLY'S LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SKELLY'S LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SKELLY'S LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| IAN SKELLY (MANCHESTER) LIMITED | 09 nov 1987 | 09 nov 1987 |
| PACIFIC SHELF 125 LIMITED | 07 jul 1987 | 07 jul 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SKELLY'S LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SKELLY'S LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 27 jul 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Bishop como director el 01 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Muir como director el 01 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SKELLY'S LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175766960001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| HOUSTON, David Oliver | Secretario | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| MACNAMARA, Richard James | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149324740001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Secretario | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Secretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Secretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Secretario corporativo | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Director | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Director | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Director | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Director | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Director | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Director | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, David Oliver | Director | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Director | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Director | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Director | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Director | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Director | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| SKELLY, Ian Barr | Director | Leewood House ML11 9JA Lanark | United Kingdom | British | 9845580001 | |||||
| SKELLY, Margaret Richmond | Director | Leewood House ML11 9JA Lanarkshire | British | 548730001 | ||||||
| STUART, John Morris | Director | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Director | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Director | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Director | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Director | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SKELLY'S LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 abr 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SKELLY'S LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Creado el 17 ene 1991 Entregado el 27 ene 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All refund of monies paid to vag united kingdom limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 06 mar 1989 Entregado el 22 mar 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 21 oct 1988 Entregado el 27 oct 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Agreement for lease in respect of premises at every st, manchester. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0