PINNACLE TELEPHONE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PINNACLE TELEPHONE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC106307 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Lochside House 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TILTALE LIMITED | 28 ago 1987 | 28 ago 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 feb 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 feb 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Joanne Sarah Finch como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christian Allen como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Nowak como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Richard Wolfgang Henry Schäfer como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Martin John Purkess el 01 jul 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 feb 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 32 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lomond House 9 George Square Glasgow G2 1QQ el 22 dic 2009 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Thomas Nowak el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christian Philip Quentin Allen el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Martin Purkess el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PINNACLE TELEPHONE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Secretario | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | England | British | 139360020001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| BALCHIN, Mark Nicholas | Secretario | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | British | 812680001 | ||||||
| COX, Homersham Martin | Secretario | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | 1058000001 | ||||||
| EMETULU, Lola | Secretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||
| JEFFERSON, Karen | Secretario | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||
| LAFFERTY, Gerard | Secretario | 18 Coney Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | 281740001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Secretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | 123612980001 | ||||||
| BREWER, Stephen | Director | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Director | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CARDELL, Michael Southwell | Director | 26 Scotts Avenue BR2 0LQ Bromley Kent | England | British | 34712930001 | |||||
| CHESWORTH, Paul | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| COX, Homersham Martin | Director | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | 1058000001 | ||||||
| DIPRE, Paul Vincent | Director | Junta Waterhouse Lane KT20 6HT Kingswood Surrey | British | 3747590001 | ||||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| EVANS, Mark | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Director | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| HANFORD, Raymond Clifford | Director | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 45868080001 | |||||
| HERROD, Harry Alan | Director | Dakar, 40 Camelon Road FK1 5SH Falkirk | British | 93998280001 | ||||||
| JONES, David Leslie | Director | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | 83517310001 | ||||||
| LAFFERTY, Gerard | Director | 18 Coney Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | 281740001 | ||||||
| LANGSTON, Edward | Director | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| MCNEILL, Ronald | Director | 32 Drummond Place EH3 6PW Edinburgh Midlothian | British | 205550001 | ||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| TOURNON, Emanuele | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 | |||||
| TOWNSEND, John Raymond | Director | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | 95223480001 | ||||||
| WALKER, Allan Ronald | Director | Highfield House Falkirk Road EH49 7SF Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 106150070001 | |||||
| WEBB, Denys William | Director | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | 76074580001 |
¿Tiene PINNACLE TELEPHONE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 28 abr 1992 Entregado el 08 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 jun 1989 Entregado el 30 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Freehold, leasehold property stocks, shares & other securities. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 16 oct 1987 Entregado el 04 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The company is subscriber base. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 16 oct 1987 Entregado el 04 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción See page 2 of doc. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0