STIRLING MARINE LIMITED

STIRLING MARINE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTIRLING MARINE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC108613
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STIRLING MARINE LIMITED?

    • (6110) /

    ¿Dónde se encuentra STIRLING MARINE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Stirling & Gilmour
    Pavilion Court
    G81 1BL 45 Kilbowie Road, Clydebank
    Dunbartonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STIRLING MARINE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIDEN SHIPPING COMPANY LIMITED07 may 199207 may 1992
    HARRISONS INTERNATIONAL LIMITED 02 oct 198902 oct 1989
    PACIFIC SHELF 150 LIMITED11 ene 198811 ene 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STIRLING MARINE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para STIRLING MARINE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STIRLING MARINE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    4 páginas4.26(Scot)

    Cese del nombramiento de Richard Ryan como director

    2 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    4 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    4 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2010

    Estado de capital el 02 jul 2010

    • Capital: GBP 334,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    12 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    11 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    12 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de STIRLING MARINE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALAIS, Steven Morton
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    Secretario
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    British2988490001
    CAMBURN, Clyde Martin
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    Director
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    EnglandBritish44503380004
    GELLERT, John Matthew
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    Director
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    United StatesAmerican70080070001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    British25620001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secretario designado corporativo
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish25620001
    BENSON, David Gillies
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    Director
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    British1856390001
    BURROWS, Ian Edwin
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British25670001
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Director
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Director
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    COWDEROY, James Anthony Frank
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    Director
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    ScotlandBritish40380390001
    HARRISON, Iain Victor Robinson
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    Director
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    ScotlandBritish38290001
    LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    Director
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    British64332640001
    RYAN, Richard James
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    Director
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    United KingdomBritish75873300001
    WILSON, Andrew George
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    Director
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    British782420001
    WORDIE, Peter Jeffrey
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    Director
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    British25640001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Director designado corporativo
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001

    ¿Tiene STIRLING MARINE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of covenant
    Creado el 10 jul 1998
    Entregado el 30 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Earnings in respect of the vessel "stirling tay".
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 jul 1998Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creado el 09 jul 1998
    Entregado el 10 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares,the earnings & requisition compensation the vessel "stirling tay".
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jul 1998Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Second priority statutory ship mortgage
    Creado el 09 jul 1998
    Entregado el 10 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jul 1998Registro de un cargo (410)
    • 08 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Creado el 09 jul 1998
    Entregado el 10 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 10 jul 1998Registro de un cargo (410)
    • 08 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Performance guarantee assignation
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 28 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All the companys beneficial interest & its rights & titles.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 ago 1997Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Assignation in security
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 28 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole right,title and interest under the contracts.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 ago 1997Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Delivery order
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 28 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The vessel, her engines,equipment,machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 ago 1997Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Shipowners form
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 28 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The company's obligations under the shipowners form
    Breve descripción
    Any moneys payable in accordance with the terms of the security documents.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 28 ago 1997Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creado el 26 ago 1996
    Entregado el 28 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Companys right,title and interest in all money payable by shell U.K. limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creado el 23 ago 1996
    Entregado el 28 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All rights,title and interest in & to the mortgaged property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Second priority statutory mortgage
    Creado el 23 ago 1996
    Entregado el 26 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the vessel "stirling forth" registered on the bahamas no. 728058.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 06 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Creado el 23 ago 1996
    Entregado el 26 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares on the vessel "stirling forth" registered in the bahamas no.728508.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 26 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 06 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Mortgage
    Creado el 09 ene 1996
    Entregado el 22 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    51/64TH shares in the ship "stirling fyne", off no 726104, registered at nassau, and her boats, guns, etc....... see ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and Others
    Transacciones
    • 22 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 09 ene 1996
    Entregado el 22 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company's rights, title and interest in the ship and its shares.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transacciones
    • 22 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Assignment
    Creado el 09 ene 1996
    Entregado el 22 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The earnings, requisition compensation, etc....... see ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transacciones
    • 22 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 08 ene 1996
    Entregado el 22 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transacciones
    • 22 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 22 ene 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 sept 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 sept 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones
    Bond & floating charge
    Creado el 08 ene 1996
    Entregado el 22 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by stirling offshore limited
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 sept 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones
    Performance guarantee assignation
    Creado el 15 dic 1995
    Entregado el 19 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company's whole beneficial interest and all its benefits, rights and titles (but not its obligations) in and under the performance guarantee dated 30/3/95 made by kvaerner A.S. in favour of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Contract assignation
    Creado el 15 dic 1995
    Entregado el 19 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company's whole rights, interests and benefits (but not its obligations) under the ship building contract dated 30/3/95, relating to the construction of a vessel to be known during construction as yard no. 310....... see ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Delivery order
    Creado el 15 dic 1995
    Entregado el 19 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The vessel known as yard no. 310 and all her engines, equipment, etc....... see ch microfiche.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Shipowners form
    Creado el 15 dic 1995
    Entregado el 19 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All sums payable under clause 10.2 of a contract assignation and clause 10 of the general terms by the company....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 19 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creado el 21 nov 1994
    Entregado el 12 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due and to become due under a loan agreement, guarantee and security documents
    Breve descripción
    By way of security for the secured indebtedness the chargor as beneficial owner mortgages and charges and agrees to mortgage asnd charge to and in favour of the chargee all its rights, title and interest, present and future, to and in the ship and to and in the shares of the ship owned by the chargor.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 dic 1994Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Four party agreement
    Creado el 21 nov 1994
    Entregado el 12 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement
    Breve descripción
    1) the head charterparty and the head charter rights 2) any requisition compensation and the earnings.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 dic 1994Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Mortgage
    Creado el 21 nov 1994
    Entregado el 12 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement and a deed of covenant
    Breve descripción
    51/64 shares, of which the chargee is owner, in the motor ship "stirling fyne" (ex edda fjord) registered on the bahamian flag at the port of nassau.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 dic 1994Registro de un cargo (410)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 21 nov 1994
    Entregado el 12 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £2,650,000 and all further sums due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 dic 1994Registro de un cargo (410)
    • 21 dic 1995Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 sept 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 sept 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones

    ¿Tiene STIRLING MARINE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 feb 2011Inicio de la liquidación
    02 oct 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0