LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LYCIDAS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC110030 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 George Square G2 1AL Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LYCIDAS (139) LIMITED | 23 mar 1988 | 23 mar 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Frank Raine Johnstone como director el 31 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Roderick Alexander Louden Harrison como director el 30 jul 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rona Nicolson Hutchison como director el 26 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Frank Raine Johnstone como director el 26 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maclay Murray & Spens Llp como secretario el 27 oct 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Dentons Secretaries Limited como secretario el 27 oct 2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Stevenson Biggart como director el 27 oct 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lorna Margaret Mccaa como director el 01 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher John William Stenning como director el 07 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Wilson Aitken como director el 07 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 292 st. Vincent Street Glasgow G2 5TQ a 1 George Square Glasgow Scotland G2 1AL el 15 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James William Rattray Mackie como director el 07 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Rona Nicolson Hutchison como director el 07 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Lorna Margaret Mccaa como director el 07 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Alexis Irene Graham como director el 07 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTONS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | EC4M 7WS London One Fleet Place United Kingdom |
| 98515470015 | ||||||||||||||
| BLYTH, Douglas John | Director | Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir 15 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | 152406590001 | |||||||||||||
| GRAHAM, Alexis Irene | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | 192109610001 | |||||||||||||
| HARRISON, Roderick Alexander Louden | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | Scotland | British | 85789520002 | |||||||||||||
| KERR, Eleanor Mary | Director | 25 Raceource Road KA7 2TE Ayr Sleaford House Ayrshire United Kingdom | Scotland | British | 42230490003 | |||||||||||||
| MAILLIE, John Parker | Secretario | 292 St Vincent Street G2 5TQ Glasgow Lanarkshire | British | 737470001 | ||||||||||||||
| LYCIDAS NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
| 900003280001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario corporativo | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom |
| 201851590001 | ||||||||||||||
| ADAMS, Mark Edward | Director | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House United Kingdom | United Kingdom | British | 162057040001 | |||||||||||||
| AITKEN, Thomas Wilson | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 981670003 | |||||||||||||
| BARR, Alan Lamont | Director | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 146620460001 | |||||||||||||
| BELL, Patrick Ian | Director | 2 Clark Road EH5 3BD Edinburgh | United Kingdom | British | 107403300001 | |||||||||||||
| BIGGART, Andrew Stevenson | Director | Lochwinnoch Road PA13 4DZ Kilmacolm Kinnoul Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | 251423620001 | |||||||||||||
| BLACKWOOD, John Grahame | Director | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 69144850003 | |||||||||||||
| BROWN, Steven | Director | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 179662800001 | |||||||||||||
| BURROW, Alistair Stewart | Director | Kintail 27 North Erskine Park Bearsden G61 4LY Glasgow | Scotland | British | 1238860006 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Morag | Director | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 35738480001 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Peter Colin | Director | 16 Campbell Road EH12 6DT Edinburgh Midlothian | British | 1089790001 | ||||||||||||||
| CHRYSTIE, Kenneth George, Dr | Director | 2 Redlands Road G12 0SJ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 70280001 | |||||||||||||
| COWIE, Mark Fraser Alexander | Director | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 69778180007 | |||||||||||||
| CROFT, Alistair Charles | Director | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House England | United Kingdom | British | 189111470002 | |||||||||||||
| CZARNOCKI, Virginia Margaret Greer | Director | 2 James View ML1 4HN Motherwell Lanarkshire | British | 96032390003 | ||||||||||||||
| DOCHERTY, Caroline | Director | 21 Beechmount Park EH12 5YT Edinburgh Midlothian | British | 1089410005 | ||||||||||||||
| DOUGAN, Mairi-Claire | Director | 15 Cramond Place Dalgety Bay KY11 9LS Dunfermline Fife | Scotland | British | 112513060001 | |||||||||||||
| DUNCAN, Euan Findlay | Director | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 81706140001 | |||||||||||||
| FIELDHOUSE, Jeremy | Director | 193 Hermitage Waterside Thomas Moore Street E1W 1YD London | British | 72875090001 | ||||||||||||||
| FRIER, George William | Director | 16 Tavistock Drive G43 2SJ Glasgow | Scotland | British | 38802850002 | |||||||||||||
| GHOSH, Ashok | Director | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House England | United Kingdom | British | 108619110001 | |||||||||||||
| GILKS, Geoffrey Paul | Director | 6 Old Palace Terrace The Green TW9 1NB Richmond Surrey | British | 69757860001 | ||||||||||||||
| GOURLAY, David Mcrae | Director | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 108622840001 | |||||||||||||
| HOGG, Derek William | Director | 112 Moira Terrace EH7 6TG Edinburgh | Scotland | British | 47129220003 | |||||||||||||
| HUTCHESON, Jeffrey Andrew | Director | Roselea 34 Woodland Grove EH15 3PP Duddingston Edinburgh | Scotland | British | 37590090001 | |||||||||||||
| HUTCHISON, Rona Nicolson | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | 199240740001 | |||||||||||||
| JOHNSTONE, Frank Raine | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 70370002 | |||||||||||||
| KERR, Scott Thomas Reid | Director | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | United Kingdom | British | 53132710001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maclay Murray & Spens Llp | 06 abr 2016 | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0