CLYDEPORT SHIPPING LIMITED

CLYDEPORT SHIPPING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLYDEPORT SHIPPING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC110769
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    16 Robertson Street
    Glasgow
    G2 8DS
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CLYDESOIL LIMITED17 jun 198817 jun 1988
    RUNPLOY LIMITED26 abr 198826 abr 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jun 2013

    Estado de capital el 18 jun 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Ian Graeme Lloyd Charnock como director el 30 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Alan Barr como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Whitworth como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009

    8 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008

    8 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de CLYDEPORT SHIPPING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Secretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165341530001
    MACKAY, Margaret Mcdade
    30 Grieve Croft, Silverwood
    Bothwell
    G71 8LU Glasgow
    Director
    30 Grieve Croft, Silverwood
    Bothwell
    G71 8LU Glasgow
    ScotlandBritish72999580001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Secretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    DAVIDSON, Euan Ferguson
    Langhaugh Devonside Road
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secretario
    Langhaugh Devonside Road
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British40857040003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Secretario
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    JOHNSTON, George Penman
    79 Dorian Drive
    Clarkston
    G76 7NY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    79 Dorian Drive
    Clarkston
    G76 7NY Glasgow
    Lanarkshire
    British916900001
    SEMPLE, Mitchell Scott
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    British365320001
    THOMSON, Stuart David Alexander
    27 Dalwhinnie Avenue
    Blantyre
    G72 9NQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    27 Dalwhinnie Avenue
    Blantyre
    G72 9NQ Glasgow
    Lanarkshire
    British666410001
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Director
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Director
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    DAVIDSON, Euan Ferguson
    Langhaugh Devonside Road
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Director
    Langhaugh Devonside Road
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British40857040003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Director
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    HODGKINSON, John Harold
    The Stables
    Ballagan
    G63 9AE Strathblane
    Stirlingshire
    Director
    The Stables
    Ballagan
    G63 9AE Strathblane
    Stirlingshire
    British79173560001
    HUNT, David
    Tynedale 40 Craignethan Road
    Giffnock
    G46 6SJ Glasgow
    Director
    Tynedale 40 Craignethan Road
    Giffnock
    G46 6SJ Glasgow
    ScotlandBritish64386280001
    JOHNSTON, George Penman
    79 Dorian Drive
    Clarkston
    G76 7NY Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    79 Dorian Drive
    Clarkston
    G76 7NY Glasgow
    Lanarkshire
    British916900001
    LAWWELL, Peter Thomas
    6 Thornhill Gardens
    Mearnskirk
    G77 5FU Glasgow
    Director
    6 Thornhill Gardens
    Mearnskirk
    G77 5FU Glasgow
    British93568460001
    MCKELLAR, Peter
    11 Spylaw Park
    EH13 0LP Edinburgh
    Lothian
    Director
    11 Spylaw Park
    EH13 0LP Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish86757180001
    MCMURRAY, Donald Brown
    80a Banchory Avenue
    Inchinnan
    Renfrewshire
    Director
    80a Banchory Avenue
    Inchinnan
    Renfrewshire
    British920340001

    ¿Tiene CLYDEPORT SHIPPING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 08 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage, fixed charges, assignments and floating charge - see form 410 paper apart for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 12 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 feb 2007
    Entregado el 08 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 12 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 22 sept 2005
    Entregado el 07 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First fixed charge over the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to uncalled capital, the investments, the shares etc. see form 410 for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 oct 2005Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 07 oct 2003
    Entregado el 18 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage, all freehold and leasehold property wheresoever situate (other than scottish heritable property) now owned by the gh chargor or in which the gh chargor may have interst; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 oct 2003Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 30 abr 2003
    Entregado el 16 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 may 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 08 sept 1998
    Entregado el 25 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 25 sept 1998Registro de un cargo (410)
    • 17 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0