THE EDI GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE EDI GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC110956 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE EDI GROUP LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra THE EDI GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Waverley Court 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE EDI GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EDINBURGH DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED | 02 dic 1991 | 02 dic 1991 |
| ENTERPRISE EDINBURGH LIMITED | 30 jun 1988 | 30 jun 1988 |
| PACIFIC SHELF 190 LIMITED | 03 may 1988 | 03 may 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE EDI GROUP LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE EDI GROUP LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE EDI GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Registro de la carga SC1109560029, creada el 04 sept 2025 | 9 páginas | MR01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||
Nombramiento de Councillor Lezley Marion Cameron como director el 06 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Meagher como director el 24 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 34 páginas | AA | ||
Nombramiento de Councillor Danny Aston como director el 27 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 36 páginas | AA | ||
Nombramiento de Councillor Jane Meagher como director el 30 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Lezley Marion Cameron como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Rosa Campbell como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 36 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr David Wylie como secretario el 09 nov 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 39 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 42 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 dic 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 42 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Cllr Iain Whyte el 11 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE EDI GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYLIE, David | Secretario | 30 Semple Street EH3 8BL Edinburgh Excel House Scotland | 284555190001 | |||||||
| ASTON, Danny, Councillor | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 325030770001 | |||||
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| WHYTE, Iain, Cllr | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 148139080002 | |||||
| BLYTH, William | Secretario | Carradale 516 Lanark Road West EH14 7DH Balerno Midlothian | British | 514950001 | ||||||
| MCGOWAN, Carol Ann | Secretario | 374 Leith Walk EH7 4PE Edinburgh Midlothian | British | 112664200001 | ||||||
| WILSON, Mary | Secretario | 3 Belgrave Road EH12 6NG Edinburgh | British | 42188180001 | ||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| ADAIR, Eric Weir | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 116185430001 | |||||
| AITCHISON, Thomas Nisbet | Director | 27 Dudley Terrace EH6 4QQ Edinburgh | British | 43674840001 | ||||||
| ANDERSON, Donald Craig | Director | 39 The Spinney EH17 7LE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 48629740001 | |||||
| ATKINSON, Elspeth, Dr | Director | The Rectory 203 Gilmore Place EH3 9PN Edinburgh | British | 51045490001 | ||||||
| BALFOUR, Jeremy Ross | Director | 107 Comiston Drive EH10 5QU Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 117838080001 | |||||
| BARRETT, John | Director | 3 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 728540001 | ||||||
| BARRIE, Gavin Knight | Director | The City Of Edinburgh Council City Chambers, High Street EH1 1YJ Edinburgh Rm 7.30 United Kingdom | Scotland | British | 206373190001 | |||||
| BEGG, David, Councillor | Director | 12/5 Mayfield Terrace EH9 1SA Edinburgh | British | 48777780003 | ||||||
| BENSON, Deborah Clare, Dr | Director | Dolphinton EH46 7AF West Linton White Hill Estate Peeblesshire Scotland | United Kingdom | British | 52845300006 | |||||
| BLACKLOCK, Angela | Director | North St. David Street EH2 1AW Edinburgh 7/9 Scotland | United Kingdom | British | 154314260002 | |||||
| BLYTH, William | Director | Carradale 516 Lanark Road West EH14 7DH Balerno Midlothian | British | 514950001 | ||||||
| BUCHANAN, Tom | Director | Dolphin House 4 Hunter Square EH1 1QW Edinburgh | United Kingdom | British | 123330960001 | |||||
| CAIRNS, Robert | Director | 70 Ratcliffe Terrace EH9 1ST Edinburgh | British | 37590200001 | ||||||
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| CAMERON, Lezley Marion | Director | 7/6 Roseburn Maltings EH12 5LY Edinburgh Midlothian | British | 77460160002 | ||||||
| CAMPBELL, Katherine Rosa | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | United Kingdom | British | 233686000001 | |||||
| CARDOWNIE, Archibald Stephen | Director | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers Scotland | Scotland | British | 179678290001 | |||||
| CARDOWNIE, Stephen Archibald | Director | 30 Bellevue Terrace EH7 4DS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 122966850001 | |||||
| CHAPMAN, Margaret Frances Mary | Director | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers United Kingdom | Scotland | South African | 132684580001 | |||||
| CHILD, Maureen Margaret, Councillor | Director | Dolphin House 4 Hunter Square EH1 1QW Edinburgh | Scotland | British | 38674860001 | |||||
| DALGETY, Susan | Director | 16 Temple Park Crescent EH11 1HT Edinburgh | British | 103240003 | ||||||
| DAY, Cameron Blyth, Cllr | Director | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers United Kingdom | United Kingdom | British | 154799320001 | |||||
| DI CIACCA, John Mark | Director | Main Road KY11 1HA North Queensferry The Red Post Fife | United Kingdom | British | 77111830002 | |||||
| DIXON, Michael Perceval | Director | 97 Dudley Avenue EH6 4PP Edinburgh Midlothian | British | 110276740001 | ||||||
| DREVER, Peng Geik | Director | 13 Northumberland Street EH3 6LL Edinburgh Midlothian | Malaysian | 69597360001 | ||||||
| DREVER, Peng Geik | Director | 13 Northumberland Street EH3 6LL Edinburgh Midlothian | Malaysian | 69597360001 | ||||||
| DUNN, Hugh John | Director | 33 Waverley Crescent Cumbernauld G67 4BG Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 124746760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE EDI GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cec Holdings Ltd | 01 jul 2016 | East Market Street Waverley Court EH8 8BG Edinburgh 4 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0