ASHBOURNE HOMES LIMITED

ASHBOURNE HOMES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASHBOURNE HOMES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC111467
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    • Actividades de la seguridad social obligatoria (84300) / Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria

    ¿Dónde se encuentra ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASHBOURNE HOMES LIMITED07 jun 198807 jun 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012

    1 páginasTM01

    Notificación de la finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4(Scot)

    Notificación del acta de la reunión que aprueba el acuerdo voluntario de los acreedores

    4 páginas1.1(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland el 20 ene 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2012

    Estado de capital el 18 ene 2012

    • Capital: GBP 33,900,000
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    27 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU el 27 jul 2010

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Lynn Fearn como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE HOMES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Director
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    LANG, Anthony
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    British557550001
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304700001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secretario
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    Secretario
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Director
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    ASPIN, David William
    Southover
    Spring Lane Burwash
    TN19 7JB Etchingham
    East Sussex
    Director
    Southover
    Spring Lane Burwash
    TN19 7JB Etchingham
    East Sussex
    British41679550002
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Director
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Director
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    BURNETT, Marion
    Ravenscourt House 21 Thornton Road
    Thorntonhall
    G74 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Ravenscourt House 21 Thornton Road
    Thorntonhall
    G74 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    British1045600001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Director
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Director
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    Director
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    British53339290001
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Director
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Director
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Director
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritish130867640001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Director
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FINNIS, Pam
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Director
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish133719530001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Director
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Director
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish111188390002
    FOULKES, Kamma
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    Director
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    United KingdomBritish111188390002

    ¿Tiene ASHBOURNE HOMES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1999
    Entregado el 24 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    288 blackburn road, bolton, lancashire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 ago 1999Registro de un cargo (410)
    • 12 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 28 feb 1997
    Entregado el 18 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal charge over land at sedbury park,sedbury,tidenham,gloucestershire.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 mar 1997Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 dic 1996
    Entregado el 06 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal charge over ladyville lodge and the orchard,fen lane,north ockenden,upminster,essex. See the mortgage charge document for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 ene 1997Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 dic 1996
    Entregado el 06 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over midfield lodge,cambridge road,oakington,cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 ene 1997Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Sunningdale nursing home,brickdale way,hull. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Highfield hall,haslingden,rossendale,lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Wordsworth house,wordsworth street,burnley,lancs. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The rowans,whalley new road,blackburn,lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1-3 beech mount,beech street,liverpool. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Edgeleigh nursing home,halifax road,littleborough,rochdale. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Brierfield nursing home,hardy avenue,pendle. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 1996
    Entregado el 21 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Broome end,pines hill,stansted,essex. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 21 nov 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 05 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Rowan court,cults,aberdeen.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 05 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Murrayfield house,murrayfield avenue,edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    234 crow road,glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Wellmeadow,wellmeadow way,newton mearns.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.park lodge,park avenue,leeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.edgeworth house,quarry road,bebington,wirral,merseyside. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.gateford hill,gateford,worksop,nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.frederick milner house,ermyn way,leatherhead,surrey. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.larklands,london road,ascot,berkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.laurel court,palantine road,manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges.grosvenor house,duchy road,harrogate. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over bamburgh court,mowbray road,south shields,tyne and wear. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 18 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over norfolk house,portmore park road,weybridge,surrey. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 sept 1996Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene ASHBOURNE HOMES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0