ASHBOURNE HOMES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ASHBOURNE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC111467 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE HOMES LIMITED?
- Actividades de la seguridad social obligatoria (84300) / Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
¿Dónde se encuentra ASHBOURNE HOMES LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHBOURNE HOMES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ASHBOURNE HOMES LIMITED | 07 jun 1988 | 07 jun 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE HOMES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE HOMES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notificación de la finalización del acuerdo voluntario | 6 páginas | 1.4(Scot) | ||||||||||
Notificación del acta de la reunión que aprueba el acuerdo voluntario de los acreedores | 4 páginas | 1.1(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland el 20 ene 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Midmer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU el 27 jul 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lynn Fearn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE HOMES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Director | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Director | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Secretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Secretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| LANG, Anthony | Secretario | 58 West Regent Street G2 2QZ Glasgow Lanarkshire | British | 557550001 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretario | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304700001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secretario | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Secretario | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BURNESS SOLICITORS | Secretario designado corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Director | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| ASPIN, David William | Director | Southover Spring Lane Burwash TN19 7JB Etchingham East Sussex | British | 41679550002 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Director | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Director | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Director | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Director | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| BURNETT, Marion | Director | Ravenscourt House 21 Thornton Road Thorntonhall G74 5AL Glasgow Lanarkshire | British | 1045600001 | ||||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Director | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||
| COLVIN, William | Director | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Director | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Director | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARMER, Nicholas John | Director | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FARRALL, Elaine Ann | Director | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEARN, Lynn | Director | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FEENEY, Martin | Director | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FINNIS, Pam | Director | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 133719530001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Director | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Director | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FOULKES, Kamma | Director | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | 111188390002 |
¿Tiene ASHBOURNE HOMES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 04 ago 1999 Entregado el 24 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 288 blackburn road, bolton, lancashire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 28 feb 1997 Entregado el 18 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal charge over land at sedbury park,sedbury,tidenham,gloucestershire. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 dic 1996 Entregado el 06 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal charge over ladyville lodge and the orchard,fen lane,north ockenden,upminster,essex. See the mortgage charge document for full details. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 dic 1996 Entregado el 06 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over midfield lodge,cambridge road,oakington,cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Sunningdale nursing home,brickdale way,hull. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Highfield hall,haslingden,rossendale,lancashire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Wordsworth house,wordsworth street,burnley,lancs. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The rowans,whalley new road,blackburn,lancashire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 1-3 beech mount,beech street,liverpool. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Edgeleigh nursing home,halifax road,littleborough,rochdale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Brierfield nursing home,hardy avenue,pendle. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 1996 Entregado el 21 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Broome end,pines hill,stansted,essex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 05 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Rowan court,cults,aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 05 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Murrayfield house,murrayfield avenue,edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 04 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 234 crow road,glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 04 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Wellmeadow,wellmeadow way,newton mearns. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.park lodge,park avenue,leeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.edgeworth house,quarry road,bebington,wirral,merseyside. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.gateford hill,gateford,worksop,nottingham. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.frederick milner house,ermyn way,leatherhead,surrey. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.larklands,london road,ascot,berkshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.laurel court,palantine road,manchester. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges.grosvenor house,duchy road,harrogate. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges over bamburgh court,mowbray road,south shields,tyne and wear. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 sept 1996 Entregado el 18 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charges over norfolk house,portmore park road,weybridge,surrey. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ASHBOURNE HOMES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA) |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0