STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC111734
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ORRMAC (NO:63) LIMITED20 jun 198820 jun 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de administración a disolución

    38 páginas2.26B(Scot)

    Declaración de la propuesta revisada del administrador

    2 páginas2.17B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    31 páginas2.20B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    29 páginas2.20B(Scot)

    Aviso de renuncia del administrador

    1 páginas2.29B(Scot)

    Aviso de renuncia del administrador

    1 páginas2.29B(Scot)

    Declaración de la propuesta considerada del administrador

    1 páginas2.16BZ(Scot)

    Declaración de asuntos con el formulario 2.13B(Scot)

    16 páginas2.15B(Scot)

    Declaración de la propuesta del administrador

    147 páginas2.16B(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL Scotland a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL el 26 sept 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginas2.11B(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL el 15 sept 2014

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Jourdain como director el 01 ago 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Procopis como director el 01 ago 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Declan Mckelvey como director el 01 ago 2014

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 abr 2014

    Estado de capital el 28 abr 2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cese del nombramiento de David Kaye como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Kaye como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    legacy

    19 páginasMG01s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCKELVEY, Declan
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    Director
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    EnglandIrish172282530001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Secretario
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    British1244320001
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Secretario
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    British39828490004
    HENDERSON, William Shields
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    British893760001
    KAYE, David Robert
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    Secretario
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    British110817160002
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secretario corporativo
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    ANDERSON, Alan William
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    Director
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    British740310001
    BRYNES, Peter
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    Director
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    British71545500001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Director
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    British1244320001
    CAMPBELL, Colin John
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British99161140001
    GALGANI, Franco
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    Director
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    British43293400002
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Director
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    United KingdomBritish39828490004
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish55090001
    JOURDAIN, Michael Edward
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    Director
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritish58412670001
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    Director
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    United KingdomBritish110817160002
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Director
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritish75936930001
    MURRAY, Rodger Grant
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    Director designado
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    British900000170001
    PAISNER, Jonathan Samuel
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Director
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    United KingdomBritish78399950005
    PROCOPIS, Peter
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    Director
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    United KingdomAustralian66047970002
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Director
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrish7856280001
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Director
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41216370001
    SIMMERS, Brian Maxwell
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1064940001
    SIMMERS, Graeme Maxwell
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    Director
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    ScotlandBritish1064950001
    SMITH, Paul Murray
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    Director
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    British1064970001
    WATSON, David James
    18 Saville Row
    London
    Director
    18 Saville Row
    London
    British1123110001

    ¿Tiene STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 03 abr 2012
    Entregado el 05 abr 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transacciones
    • 05 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    Assignation of rents
    Creado el 24 jul 2009
    Entregado el 28 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Right, title and interest in and to the rental income over stirling highland hotel, stirling.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 28 jul 2009Registro de un cargo (410)
    Deed of confirmation
    Creado el 07 jul 2009
    Entregado el 21 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Variation of previously registered floating charge, assignation of rents and standard securities-see form for further details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 21 jul 2009Registro de un cargo (410)
    Assignation of rents
    Creado el 20 sept 2007
    Entregado el 11 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Present and future right, title and interest in and to the rental income over the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporatiin PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2007Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 22 jul 2004
    Entregado el 29 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due under the transaction documents
    Breve descripción
    The tenant's interest in the lease in respect of the subjects comprising 1.88 acres of ground and known as and forming the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 29 jul 2004Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 12 jul 2004
    Entregado el 16 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transacciones
    • 16 jul 2004Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 12 abr 2002
    Entregado el 23 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 23 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 10 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 04 abr 2002
    Entregado el 12 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 12 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 21 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 21 jul 2000
    Entregado el 04 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 04 ago 2000Registro de un cargo (410)
    • 10 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 13 jul 2000
    Entregado el 27 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 27 jul 2000Registro de un cargo (410)
    • 21 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 ene 2000
    Entregado el 03 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The stirling highland hotel, stirling.
    Personas con derecho
    • De Nationale Investeringsbank N.V.
    Transacciones
    • 03 feb 2000Registro de un cargo (410)
    • 10 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 23 dic 1999
    Entregado el 13 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • De Nationale Investeringsbank N.V
    Transacciones
    • 13 ene 2000Registro de un cargo (410)
    • 21 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 11 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £400,000 and all sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease out property between central doc. Council and company dated 20/4/90.
    Personas con derecho
    • Scottish Development Agency
    Transacciones
    • 11 may 1990Registro de una carga
    • 03 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 11 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease over 1.88 acres at old high school stirling.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 may 1990Registro de una carga
    • 08 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Instrument of charge
    Creado el 20 abr 1990
    Entregado el 03 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £400,000 together with all further sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Scottish Development Agency
    Transacciones
    • 03 may 1990Registro de una carga
    • 11 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 20 abr 1990
    Entregado el 30 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 1990Registro de una carga
    • 03 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    ¿Tiene STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 sept 2014Inicio de la administración
    10 sept 2015Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    David John Whitehouse
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0