LEIDOS INNOVATIONS UK LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | LEIDOS INNOVATIONS UK LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC112421 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Dirección de la sede social | Skypark 1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN BUSINESS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 22 nov 2013 | 22 nov 2013 |
| AMOR BUSINESS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 15 may 2009 | 15 may 2009 |
| SWORD BUSINESS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 03 ene 2008 | 03 ene 2008 |
| REAL TIME ENGINEERING LIMITED | 21 sept 1988 | 21 sept 1988 |
| MACL.NO. 5 LIMITED | 25 jul 1988 | 25 jul 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Eric Alan Freeman como director el 27 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Adam Oliver Clarke como director el 27 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 164 páginas | AA | ||
Nombramiento de Daniel J. Antal como director el 01 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jerald S Howe, Jr. como director el 01 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Ms Alison Jane Noon-Jones el 08 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Ms Alison Jane Noon-Jones como director el 07 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Eric Alan Freeman como director el 07 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Carly Elizabeth Kimball como director el 07 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Fovargue como director el 07 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 162 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 162 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 173 páginas | AA | ||
Nombramiento de Carly Elizabeth Kimball como director el 24 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Nigel Samuel Dougherty como director el 24 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Corbett Reagan como director el 24 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Graham Moore como director el 24 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Simon Fovargue el 08 abr 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 175 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr James Corbett Reagan el 27 ago 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURLEY, Brendan Bernard | Secretario | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | 264629010001 | |||||||
| ANTAL, Daniel J. | Director | Presidents Street 20190 Reston 1750 Virginia United States | United States | American | 237671030001 | |||||
| CLARKE, Adam Oliver | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | United Kingdom | British | 298535190001 | |||||
| DOUGHERTY, Nigel Samuel | Director | 1000 Parkway Solent Business Park PO15 7AA Fareham Fusion 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 287641280001 | |||||
| NOON-JONES, Alison | Director | c/o Leidos Customer Experience Centre King Street SW1Y 6QY St. James 22 London United Kingdom | United Kingdom | British | 170378440001 | |||||
| TURLEY, Brendan Bernard | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | Scotland | British | 103758630001 | |||||
| BLYTH, David Alastair | Secretario | The Wickets PA1 1TB Paisley 134 Renfrewshire | British | 138332600002 | ||||||
| EMENS, Christina, Secretary | Secretario | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | 200712940001 | |||||||
| FASICK, Jeffrey Kenneth, Secretary | Secretario | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | 210969030001 | |||||||
| MACLEOD, Colin Neil | Secretario | 43 Bath Street G2 1HW Glasgow Lanarkshire | British | 72029780001 | ||||||
| NORGATE, Philip Neil | Secretario | 7 Devon Avenue TW2 6PN Twickenham Middlesex | British | 116191810001 | ||||||
| SALINGER, Dorota Anna | Secretario | Greenock Road Inchinnan PA4 9LH Renfrew India Of Inchinnan Renfrewshire Scotland | 181299430001 | |||||||
| SINCLAIR, Iain James | Secretario | 15 Cairnsmore Drive Bearsden G61 4RQ Glasgow Lanarkshire | British | 997840002 | ||||||
| VELDMAN, Raymond | Secretario | c/o Leidos Freedom Drive, M/S Fs2 16-1 20190 Reston 11955 Va United States | 238799770001 | |||||||
| ADAMS, Jennifer | Director | Kilmarnock Road G43 2DG Glasgow 314 Scotland | Scotland | British | 175338930001 | |||||
| ANTAL, Daniel J. | Director | c/o Leidos Freedom Drive, M/S Fs2 16-1 20190 Reston 11955 Virgina United States | United States | American | 237671030001 | |||||
| BALL, Stephen Robert | Director | Greenock Road Inchinnan PA4 9LH Renfrew India Of Inchinnan Renfrewshire Scotland | England | British | 115418510002 | |||||
| BLYTH, David Alastair | Director | The Wickets PA1 1TB Paisley 134 Renfrewshire | Scotland | British | 138332600002 | |||||
| BOWMAN, Martin | Director | Ardoch Grove Cambuslang G72 8HA Glasgow 8 Scotland | Scotland | British | 164495440001 | |||||
| BOYD, James | Director | 62 Merryburn Avenue G46 6DG Glasgow | United Kingdom | British | 81662090001 | |||||
| BRUCE, David | Director | Viewfield Road AB15 7XP Aberdeen 46 Scotland | Scotland | British | 44122520002 | |||||
| COOPER, Mark John | Director | Greenock Road Inchinnan PA4 9LH Renfrew India Of Inchinnan Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 181301620001 | |||||
| DAVIDSON, Gillian | Director | 77 Newton Grove Newton Mearns G77 Glasgow | British | 36442440002 | ||||||
| DAVIES, Heath John | Director | Castelnau Barnes SW13 9EX London 46 | United Kingdom | British | 105007360002 | |||||
| DOCHERTY, Gerard | Director | 99 Balbeggie Street Sandyhills G32 9HQ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1189630001 | |||||
| FILLOT, Francoise Marie | Director | 286 Route De La Glande FRANCE Limonest 69760 France | France | French | 76010150001 | |||||
| FOVARGUE, Simon | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 264435670001 | |||||
| FREEMAN, Eric Alan | Director | King Street SW1 6QY St. James 22 London United Kingdom | England | American | 319079600001 | |||||
| HENDERSON, James Wilson | Director | 67 Sycamore Drive ML3 7HF Hamilton Lanarkshire | British | 997850002 | ||||||
| HOWE, JR., Jerald S | Director | Presidents Street 20190 Reston 1750 Virginia United States | United States | American | 248799240001 | |||||
| INNES, John Douglas | Director | Ashfield Road Cults AB15 9NQ Aberdeen 20 Scotland | Scotland | British | 74703040002 | |||||
| KERR, Stuart James | Director | Dalziel Drive Pollokshields G41 4HY Glasgow 32 Scotland | Scotland | British | 175338790001 | |||||
| KIMBALL, Carly Elizabeth | Director | Presidents Street 20190 Reston 1750 Virginia United States | United States | American | 287641800001 | |||||
| LEIPER, Scott | Director | Greenock Road Inchinnan PA4 9LH Renfrew India Of Inchinnan Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 138332710002 | |||||
| LOGAN, Neil Paterson | Director | Clove Mill Wynd ML9 1NT Larkhall 18 Scotland | Scotland | British | 175338530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LEIDOS INNOVATIONS UK LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Innovations Uk Group Limited | 06 abr 2016 | 8, Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0