THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST
Visión general
| Nombre de la empresa | THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC112863 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Educación cultural (85520) / Educación
- Actividades de museos (91020) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Dirección de la sede social | The Scottish Crannog Centre Dalerb Kenmore PH15 2NX Aberfeldy Perthshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE SCOTTISH TRUST FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY | 05 oct 2016 | 05 oct 2016 |
| SCOTTISH TRUST FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY | 22 ago 1988 | 22 ago 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 48 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Madeline Ruth Clare Slaven como director el 09 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Redfern como director el 09 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Lorna Margaret Watson como director el 05 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Nadia Ness como director el 05 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Johannes Adriaan Poulisse como director el 05 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Marchant como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sean Liam Fleming como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Fiona Catherine Ballantyne como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Nicholas (Nick) Grant como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 49 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Devon Margaret Mchugh como director el 30 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Mcgregor Littlejohn como director el 06 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gordon Thomas Cook como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Scottish Crannog Centre Kenmore Perthshire PH15 2HY a The Scottish Crannog Centre Dalerb Kenmore Aberfeldy Perthshire PH15 2NX el 18 abr 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 46 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Anthony Benson como director el 09 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 4 páginas | CC04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga SC1128630003, creada el 01 mar 2024 | 13 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Williamson como director el 15 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Belinda Beecroft como director el 01 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEECROFT, Belinda | Director | Breadalbane Academy Crieff Road PH15 2DU Aberfeldy Breadalbane Academy Perthshire Scotland | Scotland | British | 311039710001 | |||||
| BENSON, Michael Anthony | Director | Ewart Cottage Foulden TD15 1UH Berwick-Upon-Tweed Ewart Cottage United Kingdom | United Kingdom | British | 204661090001 | |||||
| DUFF, John Cameron | Director | Old Crieff Road PH15 2DH Aberfeldy Tomchulan Scotland | Scotland | British | 247562480001 | |||||
| ELY, Peter George | Director | Taymouth Drive Kenmore PH15 2HJ Aberfeldy 27 Scotland | Scotland | British | 85918010001 | |||||
| FLOWER, Charlotte Amanda, Dr | Director | Acharn Kenmore PH15 2HS Aberfeldy The Old Schoolhouse Perthshire Scotland | Scotland | British | 138734580001 | |||||
| LITTLEJOHN, David Mcgregor | Director | Derby Street EH6 4SH Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | 326272410001 | |||||
| MCCLUNE, Rebecca Jean | Director | The Scottish Crannog Centre Kenmore PH15 2HY Perthshire | Scotland | British,American | 247925110003 | |||||
| NESS, Nadia | Director | Prospecthill Road G42 9LE Glasgow 42 Prospecthill Road Scotland | Scotland | Scottish | 333459180001 | |||||
| POULISSE, Johannes Adriaan | Director | Dalshian PH16 5TD Pitlochry Shepherds Home Scotland | Scotland | Dutch | 333458930001 | |||||
| REDFERN, Neil | Director | Rawcliffe Avenue YO30 5QD York 1 Rawcliffe Avenue England | England | British | 333720580001 | |||||
| SLAVEN, Madeline Ruth Clare | Director | Argyle Street OX4 1SS Oxford 22 Argyle Street England | England | British | 333723820001 | |||||
| WATSON, Lorna Margaret | Director | Ballinlaggan Acharn PH15 2HT Aberfeldy 12 Ballinlaggan Scotland | Scotland | Scottish | 333459520001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael James | Director | Perth & Kinross Council 2 High Street PH1 5PH Perth 2 Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 312832520001 | |||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Secretario | 19 Midmar Gardens EH10 6DY Edinburgh Midlothian | Scottish | 40493130002 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Secretario designado | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| ANDRIAN, Barbara Louise | Director | Viewfield Acharn PH15 2HU Aberfeldy Perthshire | Scotland | American | 884140003 | |||||
| BALLANTYNE, Fiona Catherine | Director | Palmerston Road EH9 1TL Edinburgh 15 Scotland | Scotland | British | 30644460001 | |||||
| CAMPBELL, William Robert, Dr | Director | KY15 4SJ Logie Lucklaw House Fife | Scotland | British | 132596350001 | |||||
| COOK, Gordon Thomas | Director | Strathyre Place FK5 4WQ Larbert 16 Strathyre Place Scotland | United Kingdom | British | 85489010002 | |||||
| CRAIK, Douglas William | Director | Taybridge Terrace PH15 2BS Aberfeldy Strawberrybank Perthshire Scotland | Scotland | British | 126613500001 | |||||
| DAWSON, John Barry, Professor | Director | Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh 49 Midlothian | British | 132213080001 | ||||||
| DIXON, Thomas Nicholas, Dr | Director | Viewfield Acharn PH15 2HU Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | 75697280003 | |||||
| FLEMING, Sean Liam | Director | Eagle Avenue PH3 1GD Auchterarder 5 Scotland | Scotland | British | 260205860001 | |||||
| GRANT, Ian Nicholas (Nick) | Director | Fearnan PH15 2PF Aberfeldy Tigh Na Clachan Scotland | Scotland | British | 208898020001 | |||||
| HARDING, Dennis William | Director | Hill Top Cottage Hill Road EH31 2BE Gullane East Lothian | British | 884160002 | ||||||
| JEPSON, Michael Ronald | Director | 122 Lone Kauri Road Karekare FOREIGN Auckland New Zealand | British | 850410002 | ||||||
| LEIGHTON, Gordon James | Director | The Beeches PH15 2BZ Aberfeldy 2 Perthshire Scotland | Scotland | Scottish | 127663970001 | |||||
| MARCHANT, Simon | Director | Milton TA12 6AL Martock 3 Milton England | England | British | 198605110002 | |||||
| MASON, Peter John | Director | 5 Little Carron Gardens KY16 8QL St Andrews Fife | British | 35681430003 | ||||||
| MCHUGH, Devon Margaret, Dr | Director | Pilrig Street EH6 5AS Edinburgh 74 Pilrig Street Scotland | Scotland | British,American | 310507870001 | |||||
| MCTEAGUE, Katrina Trudy | Director | 13 Royal Park Terrace EH8 8JB Edinburgh Midlothian | British | 1154140001 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Director | 19 Midmar Gardens EH10 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | Scottish | 40493130002 | |||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Director designado | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Director designado | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| OPPENHEIM, William | Director | Acharn PH15 2HU Aberfeldy Altchoaran Perthshire Scotland | Scotland | American | 89060620001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE SCOTTISH CRANNOG CENTRE TRUST?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 30 may 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0