MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC115235
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    201 West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MILLER (ASIA) LIMITED28 oct 199628 oct 1996
    MILLER OVERSEAS LIMITED29 nov 199429 nov 1994
    MILLER JOINT VENTURES LIMITED30 may 198930 may 1989
    SLOTBRIGHT LIMITED16 dic 198816 dic 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Sutherland el 16 oct 2020

    2 páginasCH01

    Notification de Milsut2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2020

    2 páginasPSC02

    Cessation de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2020

    1 páginasPSC07

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2020

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2019 au 30 abr 2020

    1 páginasAA01

    Modification des détails de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 feb 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW el 05 feb 2020

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW el 04 feb 2020

    1 páginasAD01

    Cessation de Mdl Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 abr 2019

    3 páginasPSC07

    Notification de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 abr 2019

    4 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    12 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL el 25 ene 2019

    2 páginasAD01

    Cancelación total de la carga SC1152350004

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Euan James Edward Haggerty como director el 30 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kirsty Fraser Macgregor como secretario el 31 may 2017

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MILLOY, David Thomas
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    Director
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish76474600001
    SUTHERLAND, Andrew
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    Director
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    CanadaBritish66368290041
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Secretario
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    British41273760002
    DUFFIELD, Sheelagh Jane
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Secretario
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    British170591090001
    LAWSON, Gordon Kenneth
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    Secretario
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    British145330001
    MACGREGOR, Kirsty Fraser
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Secretario
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    195963090001
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Secretario
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Secretario
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    British65057960002
    BALLARD, Michael George
    72 Craigleith View
    EH4 3JY Edinburgh
    Midlothian
    Director
    72 Craigleith View
    EH4 3JY Edinburgh
    Midlothian
    British42894290001
    BORLAND, Donald William
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish66010670002
    BRADBURY, Toby Jonathan
    Hillsgate Chapel Lane
    Penistone
    S36 6AQ Sheffield
    Director
    Hillsgate Chapel Lane
    Penistone
    S36 6AQ Sheffield
    British55511210001
    CLARK, Alexander Wilson
    44 Birkhill Road
    Cambusbarron
    FK7 9JS Stirling
    Stirlingshire
    Director
    44 Birkhill Road
    Cambusbarron
    FK7 9JS Stirling
    Stirlingshire
    British500420001
    CLARKE, Robert Anthony
    6 The Paddock
    Sandy Loan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    Director
    6 The Paddock
    Sandy Loan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    British3221280003
    HAGGERTY, Euan James Edward
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish162679260001
    HODSDEN, Richard David
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    EnglandBritish183337930001
    IKE, Henry Max
    6 Hutton Close
    Nether Poppleton
    YO26 6PJ York
    North Yorkshire
    Director
    6 Hutton Close
    Nether Poppleton
    YO26 6PJ York
    North Yorkshire
    Dutch67313250001
    JACKSON, Julie Mansfield
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    Director
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    United KingdomBritish94193070001
    JOHNSTON, Neil William
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish109876070001
    JOHNSTON, Neil William
    12 Winton Gardens
    EH10 7ET Edinburgh
    Director
    12 Winton Gardens
    EH10 7ET Edinburgh
    British58059470001
    LAMB, Alan Clive
    17 Chetwynd Road
    SO16 3JA Southampton
    Hampshire
    Director
    17 Chetwynd Road
    SO16 3JA Southampton
    Hampshire
    British61933620001
    MCCULLOCH, Robert Mitchell Ogilvie
    The Saplings 16 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    The Saplings 16 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DN Leeds
    West Yorkshire
    British27174530001
    MILLER, Keith Manson
    Cherry Hollows
    1(B)Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Cherry Hollows
    1(B)Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish546650002
    MILLER, Philip Hartley
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish28512070005
    OGILVIE, Ian
    12 Old Boyne Hill Farm
    Wood Lane Chapelthorpe
    WF4 3JL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    12 Old Boyne Hill Farm
    Wood Lane Chapelthorpe
    WF4 3JL Wakefield
    West Yorkshire
    British42582570002
    PEET, Roderick
    Laughton House
    23 Hailgate, Howden
    DN14 7SL Goole
    North Humberside
    Director
    Laughton House
    23 Hailgate, Howden
    DN14 7SL Goole
    North Humberside
    EnglandBritish67313470001
    RICHARDS, John Steel
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish1318380002
    RICHARDS, John Steel
    21 Lovedale Road
    EH14 7DW Balerno
    Glendaruel
    Director
    21 Lovedale Road
    EH14 7DW Balerno
    Glendaruel
    United KingdomBritish1318380001
    SHAW, John Clifford Barratt
    Portelet 61 Oldway Drive
    B91 3HP Solihull
    West Midlands
    Director
    Portelet 61 Oldway Drive
    B91 3HP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish18542070001
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Director
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish65057960002
    WOOD, Marlene
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Director
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish31152030002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Milsut2 Limited
    West George Street
    G2 2LW Glasgow
    201
    Scotland
    30 jul 2020
    West George Street
    G2 2LW Glasgow
    201
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies Scotland
    Número de registroSc666220
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    F&J Ventures Limited
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    22 abr 2019
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalScotland
    Lugar de registroRegister Of Companies (Scotland)
    Número de registroSc623515
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro09859350
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 oct 2015
    Entregado el 14 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 06 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 feb 2012
    Entregado el 08 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 06 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 29 feb 2012
    Entregado el 08 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 06 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 20 abr 1999
    Entregado el 30 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 abr 1999Registro de un cargo (410)
    • 25 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0