MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC115235 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 201 West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MILLER (ASIA) LIMITED | 28 oct 1996 | 28 oct 1996 |
| MILLER OVERSEAS LIMITED | 29 nov 1994 | 29 nov 1994 |
| MILLER JOINT VENTURES LIMITED | 30 may 1989 | 30 may 1989 |
| SLOTBRIGHT LIMITED | 16 dic 1988 | 16 dic 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andrew Sutherland el 16 oct 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Notification de Milsut2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2020 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2019 au 30 abr 2020 | 1 páginas | AA01 | ||
Modification des détails de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 feb 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW el 05 feb 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW el 04 feb 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cessation de Mdl Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 abr 2019 | 3 páginas | PSC07 | ||
Notification de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 abr 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 12 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL el 25 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Cancelación total de la carga SC1152350004 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Euan James Edward Haggerty como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kirsty Fraser Macgregor como secretario el 31 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLOY, David Thomas | Director | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Director | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Canada | British | 66368290041 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Secretario | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 170591090001 | ||||||
| LAWSON, Gordon Kenneth | Secretario | 5 Trench Knowe EH10 7HL Edinburgh | British | 145330001 | ||||||
| MACGREGOR, Kirsty Fraser | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | 195963090001 | |||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Secretario | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| BALLARD, Michael George | Director | 72 Craigleith View EH4 3JY Edinburgh Midlothian | British | 42894290001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BRADBURY, Toby Jonathan | Director | Hillsgate Chapel Lane Penistone S36 6AQ Sheffield | British | 55511210001 | ||||||
| CLARK, Alexander Wilson | Director | 44 Birkhill Road Cambusbarron FK7 9JS Stirling Stirlingshire | British | 500420001 | ||||||
| CLARKE, Robert Anthony | Director | 6 The Paddock Sandy Loan EH31 2BW Gullane East Lothian | British | 3221280003 | ||||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| HODSDEN, Richard David | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | England | British | 183337930001 | |||||
| IKE, Henry Max | Director | 6 Hutton Close Nether Poppleton YO26 6PJ York North Yorkshire | Dutch | 67313250001 | ||||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Director | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 109876070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Director | 12 Winton Gardens EH10 7ET Edinburgh | British | 58059470001 | ||||||
| LAMB, Alan Clive | Director | 17 Chetwynd Road SO16 3JA Southampton Hampshire | British | 61933620001 | ||||||
| MCCULLOCH, Robert Mitchell Ogilvie | Director | The Saplings 16 Church Lane Bardsey LS17 9DN Leeds West Yorkshire | British | 27174530001 | ||||||
| MILLER, Keith Manson | Director | Cherry Hollows 1(B)Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| OGILVIE, Ian | Director | 12 Old Boyne Hill Farm Wood Lane Chapelthorpe WF4 3JL Wakefield West Yorkshire | British | 42582570002 | ||||||
| PEET, Roderick | Director | Laughton House 23 Hailgate, Howden DN14 7SL Goole North Humberside | England | British | 67313470001 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 1318380002 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Director | 21 Lovedale Road EH14 7DW Balerno Glendaruel | United Kingdom | British | 1318380001 | |||||
| SHAW, John Clifford Barratt | Director | Portelet 61 Oldway Drive B91 3HP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 18542070001 | |||||
| SMYTH, Pamela June | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 65057960002 | |||||
| WOOD, Marlene | Director | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milsut2 Limited | 30 jul 2020 | West George Street G2 2LW Glasgow 201 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| F&J Ventures Limited | 22 abr 2019 | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mdl Investments Limited | 06 abr 2016 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 08 oct 2015 Entregado el 14 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 feb 2012 Entregado el 08 mar 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 29 feb 2012 Entregado el 08 mar 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 20 abr 1999 Entregado el 30 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0