SCOTTISH YOUTH DANCE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSCOTTISH YOUTH DANCE
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC115368
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SCOTTISH YOUTH DANCE?

    • Artes escénicas (90010) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Dirección de la sede social
    South Block
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SCOTTISH YOUTH DANCE FESTIVAL28 dic 198828 dic 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTTISH YOUTH DANCE?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el30 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta30 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence14 may 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta30 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    33 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Oluyemi Kayode Olususi como director el 20 feb 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Abimbola Christiana Odedeyi como director el 20 feb 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Dr Bethany Whiteside como director el 15 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Elodie Lemaire Nowinski como director el 15 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christopher John Stenton como director el 15 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms. Ethelinda Lashley-Scott como director el 19 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Ruth Walker como director el 19 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Carolyn Anne Lappin como director el 19 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Kelly Shearer como secretario el 19 sept 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Carolyn Anne Lappin como secretario el 19 sept 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Sue Mitchell como director el 19 sept 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    29 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard Scholefield como director el 12 jul 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    34 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ian Dewar como director el 02 sept 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lucy Vaughan como director el 02 sept 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Taryn Murray como director el 01 sept 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    33 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de The Briggait 141 Bridgegate Glasgow G1 5HZ a South Block 60-64 Osborne Street Glasgow G1 5QH el 22 nov 2022

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Colin Fyfe como director el 13 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHEARER, Kelly
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Secretario
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    327480080001
    BUSBY, Alan Hunter
    Ydance, The Briggait
    141 Bridgegate
    G1 5HZ Glasgow
    141
    Scotland Wide
    United Kingdom
    Director
    Ydance, The Briggait
    141 Bridgegate
    G1 5HZ Glasgow
    141
    Scotland Wide
    United Kingdom
    ScotlandBritish179671800001
    CAMPBELL, Theresa
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandBritish202128830001
    CLARK, Anita Elizabeth
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandScottish245922550001
    DANIEL, Katie
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandBritish289029290001
    LASHLEY-SCOTT, Ethelinda, Ms.
    West Mains Road
    EH9 3BG Edinburgh
    17
    Scotland
    Director
    West Mains Road
    EH9 3BG Edinburgh
    17
    Scotland
    ScotlandScottish281778960001
    LEMAIRE NOWINSKI, Elodie
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandFrench329513200001
    ODEDEYI, Abimbola Christiana, Mrs.
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandNigerian315827940001
    OLUSUSI, Oluyemi Kayode
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandNigerian332934780001
    SCHOLEFIELD, Richard
    South Block, Unit 103,
    60 - 64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    60
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Director
    South Block, Unit 103,
    60 - 64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    60
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish325352980001
    STENTON, Christopher John
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    EnglandBritish293601830001
    WALKER, Ruth
    Ward Place
    EH54 6FB Livingston
    1
    Scotland
    Director
    Ward Place
    EH54 6FB Livingston
    1
    Scotland
    ScotlandBritish327547430001
    WHITESIDE, Bethany, Dr
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandBritish329793010001
    CHINN, Amanda Ruth
    32 Westfield Avenue
    KY15 5AA Cupar
    Fife
    Secretario
    32 Westfield Avenue
    KY15 5AA Cupar
    Fife
    British37530090001
    LAPPIN, Carolyn Anne
    115 Blairbeth Road
    G73 5BT Glasgow
    Secretario
    115 Blairbeth Road
    G73 5BT Glasgow
    British82213130001
    MILLER JUDD, Pauline Claire
    Fl 1 South Charlotte Street
    EH2 4AN Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    Fl 1 South Charlotte Street
    EH2 4AN Edinburgh
    Midlothian
    British21706910002
    SAVIN, Judith Valerie
    4 Park Gardens
    EH16 6JF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    4 Park Gardens
    EH16 6JF Edinburgh
    Midlothian
    British66258020002
    STEWART, Clare
    23 Bellevue Road
    EH7 4DL Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    23 Bellevue Road
    EH7 4DL Edinburgh
    Midlothian
    British1120360001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    AGATE, Jenna Gail
    19 The Green
    TD7 5AA Selkirk
    Selkirkshire
    Director
    19 The Green
    TD7 5AA Selkirk
    Selkirkshire
    ScotlandBritish18961730001
    ALLISON, Mary
    18 Craighall Crescent
    EH6 4RZ Edinburgh
    Director
    18 Craighall Crescent
    EH6 4RZ Edinburgh
    British90644070001
    ARMSTRONG, Gillian Leslie
    84 Thimblehall Drive
    KY12 7RP Dunfermline
    Fife
    Director
    84 Thimblehall Drive
    KY12 7RP Dunfermline
    Fife
    British19234790001
    BANKS, Ai-Lien
    28 Yerton Brae
    KA23 9HL West Kilbride
    Ayrshire
    Director
    28 Yerton Brae
    KA23 9HL West Kilbride
    Ayrshire
    British82212880002
    BORLAND, Michelle Andrea
    Grantley Gardens
    G41 3PZ Glasgow
    2/2, 16
    Scotland
    Director
    Grantley Gardens
    G41 3PZ Glasgow
    2/2, 16
    Scotland
    ScotlandCanadian165660420003
    BRADY, Philip John
    Shepford Place
    ML5 1RS Coatbridge
    2
    Lanarkshire
    Director
    Shepford Place
    ML5 1RS Coatbridge
    2
    Lanarkshire
    United KingdomBritish114096300001
    BREW, Marc Robert
    134 Renfrew Street
    G3 6ST Glasgow
    10/3 Fleming House
    Scotland
    Director
    134 Renfrew Street
    G3 6ST Glasgow
    10/3 Fleming House
    Scotland
    ScotlandAustralian183377380001
    BROOKS, Pauline
    157a West Stirling Street
    FK12 5EL Alva
    Clackmannanshire
    Director
    157a West Stirling Street
    FK12 5EL Alva
    Clackmannanshire
    British37368950001
    BUSBY, Alan Hunter
    Hayes Grove
    G83 0UX Alexandria
    10
    Dunbartonshire
    Scotland
    Director
    Hayes Grove
    G83 0UX Alexandria
    10
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish179671800001
    CASSIDY, Catherine Elizabeth
    Pond Green
    PH2 7PX Errol
    Campsie Buildings
    Perthshire
    Director
    Pond Green
    PH2 7PX Errol
    Campsie Buildings
    Perthshire
    ScotlandBritish136398850001
    CHERRY, Margaret
    20 Warrender Park Crescent
    EH9 1EA Edinburgh
    Director
    20 Warrender Park Crescent
    EH9 1EA Edinburgh
    ScotlandBritish38927770001
    CHINN, Frank Nicol
    32 Westfield Avenue
    KY15 5AA Cupar
    Fife
    Director
    32 Westfield Avenue
    KY15 5AA Cupar
    Fife
    ScotlandBritish66753480001
    CLAPPERTON, Margaret Marion
    Clintton Studio, 138 Whitehouse Loan
    EH9 2AN Edinburgh
    Director
    Clintton Studio, 138 Whitehouse Loan
    EH9 2AN Edinburgh
    British82213010001
    CLITHEROE, Deirdre Ann
    Sherbrooke Avenue
    G41 4SB Glasgow
    50a
    United Kingdom
    Director
    Sherbrooke Avenue
    G41 4SB Glasgow
    50a
    United Kingdom
    British116516990003
    CROSS, Mhairi Jane
    65 Beech Crescent
    FK5 3EX Larbert
    Stirlingshire
    Director
    65 Beech Crescent
    FK5 3EX Larbert
    Stirlingshire
    ScotlandBritish246106800001
    DEWAR, Ian
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    Director
    60-64 Osborne Street
    G1 5QH Glasgow
    South Block
    Scotland
    ScotlandBritish1028070001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SCOTTISH YOUTH DANCE?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    30 abr 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0