ARMA DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ARMA DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC116213 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Dirección de la sede social | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CLYDE MARITIME (PROPERTIES) LIMITED | 03 jul 1989 | 03 jul 1989 |
PACIFIC SHELF 239 LIMITED | 15 feb 1989 | 15 feb 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de John Alexander Schofield como director el 30 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Peter Whittaker como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2022 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Peel Holdings (Glasgow Harbour) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 feb 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mr Steven Keith Underwood el 02 nov 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Alexander Schofield el 02 nov 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Ruth Helen Woodhead como director el 15 ene 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Peel Holdings (Glasgow Harbour) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 nov 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Neil Lees como director el 15 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Neil Lees como secretario el 15 oct 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Ruth Helen Woodhead como director el 17 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Notification de Peel Holdings (Glasgow Harbour) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 ago 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Glasgow Harbour Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 ago 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Peter John Hosker como director el 19 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDERWOOD, Steven Keith | Director | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building England | United Kingdom | British | Director | 162134250001 | ||||
WHITTAKER, John Peter | Director | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire | United Kingdom | British | Company Director | 200357190001 | ||||
WHITTAKER, John | Director | Ballasalla IM9 3DL Malew Billown Mansion Isle Of Man | Isle Of Man | British | Director | 1614010001 | ||||
BLACKWELL, Anne Christine | Secretario | 18 Bettespol Meadows Redbourn AL3 7EW St Albans Hertfordshire | British | Secretary | 1216410001 | |||||
FEGAN, Michael Melvyn | Secretario | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
FERGUSON, Iain Donald | Secretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||
FERGUSON, Iain Donald | Secretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||
GREEN, David Simon | Secretario | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | Chartered Accountant | 42038120003 | |||||
LEES, Neil | Secretario | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | British | 29912450002 | ||||||
LINTOTT, Christopher Guy | Secretario | Everley Farmhouse Iwerne Stepleton Everley DT11 8PT Blandford Forum Dorset | British | Director | 69994230001 | |||||
SEMPLE, Mitchell Scott | Secretario | Bonnyton Cottage Eaglesham G76 0PY Glasgow Lanarkshire | British | Chartered Accountant | 365320001 | |||||
ALLISON, Thomas Eardley | Director | Rockdale Lodge 23 Park Place FK7 9JR Stirling Scotland | Scotland | British | Director | 1037730004 | ||||
ASPIN, David William | Director | Southover Spring Lane Burwash TN19 7JB Etchingham East Sussex | British | Director | 41679550002 | |||||
CUMMINGS, Peter Joseph | Director | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | Bank Official | 68241910003 | ||||
DEIGMAN, Patrick | Director | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Building Surveyor | 37099910001 | ||||
GREEN, David Simon | Director | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | Director | 42038120003 | |||||
HOSKER, Peter John | Director | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 156229430001 | ||||
JAMIESON, Euan | Director | Mauldslie House Mauldslie Rosebank ML8 5QE Carluke Lanarkshire | United Kingdom | British | Company Director | 53358690001 | ||||
LEES, Neil | Director | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | United Kingdom | British | Company Secretary | 29912450006 | ||||
MACEACHARN, Malcolm William Bruce | Director | Collihole Farm TQ13 8DY Chagford Devon | British | Banker | 26089200002 | |||||
MACECHERN, Gavin Macalister | Director | 45 Burnaby Street SW10 0PW London | British | Solicitor | 90763340001 | |||||
MCALPINE, Cullum | Director | The Manor House Cold Ashton SN14 8JU Chippenham Wiltshire | England | British | Civil Eng+Bld Contractor | 10866460002 | ||||
MITCHELL, George Edward | Director | 4b Essex Road EH4 6LE Edinburgh | Scotland | British | Divisional Chief Exec Corp Ban | 985140002 | ||||
MITCHELL-THOMSON, Malcolm Mceacharn, Lord Selsdon | Director | 66 Cadogan Place SW1X 9RS London | England | British | Surveyor | 40184790001 | ||||
MOORE, Gordon | Director | 20 Cairnhill Road Bearsden G61 1AU Glasgow Lanarkshire | British | Bank Official | 65092990001 | |||||
SCHOFIELD, John Alexander | Director | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building England | United Kingdom | British | Accountant | 103613040002 | ||||
SCHOFIELD, John Alexander | Director | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 103613040002 | ||||
SCOTT, Peter Anthony | Director | 6 Bowling Green Way Bamford OL11 5QQ Rochdale Lancashire | British | Director | 1674500002 | |||||
SIMPSON, Andrew Christopher | Director | Park Road WA15 9NN Hale 24 Cheshire United Kingdom | England | British | Company Director | 112776340002 | ||||
WAINSCOTT, Paul Philip | Director | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | United Kingdom | British | Director | 1549660002 | ||||
WOODHEAD, Ruth Helen | Director | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 204226210002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ARMA DEVELOPMENTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peel L&P Holdings (Glasgow Harbour) Limited | 18 ago 2016 | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Glasgow Harbour Limited | 06 abr 2016 | Robertson Street G2 8DS Glasgow 16 Lanarkshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ARMA DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creado el 07 oct 2003 Entregado el 18 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción By way of first legal mortgage, all freehold and leasehold property wheresoever situate (other than scottish heritable property) now owned by the gh chargor or in which the gh chargor may have interst; fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0