PROPAC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROPAC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC118170
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROPAC LIMITED?

    • Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra PROPAC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Building 3 Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    South Lanarkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROPAC LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JGT MARKETING SERVICES LIMITED19 jul 199019 jul 1990
    CRAIGTON PACKAGING LIMITED22 ago 198922 ago 1989
    FORTUNA TRADING LIMITED26 may 198926 may 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROPAC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PROPAC LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROPAC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de * 26 Netherhall Road Netherton Industrial Est Wishaw Lanarkshire ML2 0JG* el 06 feb 2014

    2 páginasAD01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2013

    Estado de capital el 02 sept 2013

    • Capital: GBP 1,339,940
    SH01

    Nombramiento de Mr Giovanni Benedetti como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Palmer como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Andrew Palmer como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Andrew Palmer como secretario

    3 páginasAP03

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2008

    8 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    15 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas122

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    18 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PROPAC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENEDETTI, Giovanni
    Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    Building 3
    South Lanarkshire
    Secretario
    Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    Building 3
    South Lanarkshire
    175994590001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Director
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    United KingdomItalian90520001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Secretario
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Italian90520001
    CALDWELL, Graham Ronald
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    Secretario
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    British7015840001
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Secretario
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    British111876120001
    CRAIG, Thomas Kirk
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Secretario
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    British5050002
    FINLAY, William Mcturk
    35 Mount Charles Crescent
    Doonfoot
    KA7 4PA Ayr
    Ayrshire
    Secretario
    35 Mount Charles Crescent
    Doonfoot
    KA7 4PA Ayr
    Ayrshire
    British74380400001
    GENTLES, John Donald
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    British320650001
    HARROWELL, Graeme Nigel
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    British68531440001
    HUGHES, Keith John
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British735110001
    OWENS, Anthony
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    Secretario
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    British86285020002
    PALMER, Andrew
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Secretario
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    British163890150001
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secretario
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    British53458580003
    CALDWELL, Graham Ronald
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    Director
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    British7015840001
    CRAIG, Thomas Kirk
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Director
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    United KingdomBritish5050002
    GALSTON, Ian
    49 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EX Glasgow
    Director
    49 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EX Glasgow
    British51403440001
    GENTLES, John Donald
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish320650001
    HARROWELL, Graeme Nigel
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    British68531440001
    HUGHES, Keith John
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British735110001
    JOHNSTONE, Marjory Jane
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British748350001
    THOMSON, Gilmour M A
    16 Crosbie Woods
    PA2 0SG Paisley
    Renfrewshire
    Director
    16 Crosbie Woods
    PA2 0SG Paisley
    Renfrewshire
    British922850001

    ¿Tiene PROPAC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 31 ene 1997
    Entregado el 10 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Benedetti International Limited
    Transacciones
    • 10 feb 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 abr 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 31 ene 1997
    Entregado el 03 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1997Registro de un cargo (410)
    • 26 mar 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 31 ene 1997
    Entregado el 03 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Scottish Enterprise
    Transacciones
    • 03 feb 1997Registro de un cargo (410)
    • 26 mar 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 21 oct 1996
    Entregado el 25 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Kellock Limited
    Transacciones
    • 25 oct 1996Registro de un cargo (410)
    • 15 nov 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 02 abr 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 27 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 12 may 1995
    Entregado el 23 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Netherhall road,wishaw.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 may 1995Registro de un cargo (410)
    • 28 mar 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (419b)
    • 18 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 25 mar 1994
    Entregado el 29 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 mar 1994Registro de un cargo (410)
    • 15 nov 1996Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 07 abr 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 10 feb 1993
    Entregado el 18 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 18 feb 1993Registro de un cargo (410)
    • 18 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0