RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED

RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC120673
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    • fabricación de motores y turbinas, excepto motores de aviones, vehículos y ciclos (28110) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rwg (Repair & Overhauls) Limited Kirkhill Drive
    Kirkhill Industrial Estate, Dyce
    AB21 0EU Aberdeen
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROLLS WOOD GROUP (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED21 mar 199021 mar 1990
    ROLESPEC LIMITED09 oct 198909 oct 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2026
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2027
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 sept 2026
    Próxima declaración de confirmación vence17 sept 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 sept 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Ross Llyod Keyzer-Dean como director el 24 abr 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Philip Paul O'brien como director el 24 abr 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Darren John Davidson como director el 24 abr 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Paul Gray como director el 24 abr 2026

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2025

    53 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Sir Ian Wood House Hareness Road Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LE Scotland a Rwg (Repair & Overhauls) Limited Kirkhill Drive Kirkhill Industrial Estate, Dyce Aberdeen AB21 0EU el 13 ene 2026

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Darren Murray Anderson como director el 31 dic 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Jay Blaskoski como director el 31 dic 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Grant Rae Angus como director el 31 dic 2025

    1 páginasTM01

    Cessation de Jwg Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2025

    1 páginasPSC07

    Modification des détails de Siemens Energy Global Gmbh & Co. Kg en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2025

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr Philip Paul O'brien como secretario el 12 ene 2026

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Grant Rae Angus como secretario el 31 dic 2025

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Darren Murray Anderson como director el 31 jul 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin Simmonite como director el 31 jul 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024

    51 páginasAA

    Modification des détails de Jwg Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov 2023

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023

    50 páginasAA

    Nombramiento de Mr Martin Simmonite como director el 15 may 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ellis Steven Renforth como director el 15 may 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Grant Rae Angus como director el 31 dic 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Grant Rae Angus como secretario el 31 dic 2023

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    O'BRIEN, Philip Paul
    Kirkhill Drive
    Dyce
    AB21 0EU Aberdeen
    Rwg (Repair & Overhauls) Limited
    Scotland
    Secretario
    Kirkhill Drive
    Dyce
    AB21 0EU Aberdeen
    Rwg (Repair & Overhauls) Limited
    Scotland
    344205080001
    DAVIDSON, Darren John
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    Director
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    EnglandBritish317612200001
    JAROS, Richard
    The Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Siemens Itcl
    England
    Director
    The Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Siemens Itcl
    England
    EnglandNorwegian242719440002
    KEYZER-DEAN, Ross Llyod
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    Director
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    EnglandBritish241326130002
    O'BRIEN, Philip Paul
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    Director
    C A Parsons Works
    Shields Road
    NE6 2YL Newcastle Upon Tyne
    Siemens Energy Limited
    England
    EnglandBritish300691850002
    SCHLELEIN, Matthias Philipp
    70-80 Franken Str
    Nuernberg, 90461
    Siemens Ag
    Germany
    Director
    70-80 Franken Str
    Nuernberg, 90461
    Siemens Ag
    Germany
    GermanyGerman265390110001
    ANGUS, Grant Rae
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Secretario
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    317619570001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Secretario
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    British36752260001
    CASTRO, Carolina De Camargo Bicudo De
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Secretario
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    178040690001
    DINOZZI, Antonio Vincenzo
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Secretario
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    256050240001
    GILMAN, Nicholas Charles
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Secretario
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    183995830001
    GOOD, Graham
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    Secretario
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    British57781370001
    SPENCE, Stuart
    42 Oakhill Road
    AB15 5ES Aberdeen
    Secretario
    42 Oakhill Road
    AB15 5ES Aberdeen
    British94023190001
    WATSON, Christopher Edward Milne
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Secretario
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    British60315030002
    WATSON, Christopher Edward Milne
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    Secretario
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    British60315030001
    ANDERSON, Darren Murray
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Director
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    ScotlandBritish120565070002
    ANGUS, Grant Rae
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Director
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    ScotlandBritish197743170001
    BAILLIE, David Charles
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Director
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Great BritainBritish89636000001
    BANKS, Craig
    Mains Of Grandholm
    Danestone
    AB22 8AR Aberdeen
    Director
    Mains Of Grandholm
    Danestone
    AB22 8AR Aberdeen
    British72547540002
    BEAUMONT, Christopher William
    Wingrove House
    St Helens Lane
    NE45 5JD Corbridge
    Northumberland
    Director
    Wingrove House
    St Helens Lane
    NE45 5JD Corbridge
    Northumberland
    British11513850001
    BLASKOSKI, Nicholas Jay
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Director
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    United StatesAmerican188001180001
    BLASKOSKI, Nicholas Jay
    277 Larkspur Court
    Zionville
    46077 Indianapolis
    Indiana
    Usa
    Director
    277 Larkspur Court
    Zionville
    46077 Indianapolis
    Indiana
    Usa
    American58522870001
    BODY, Rex John
    Englewood
    Westbury-On-Trym
    Bristol
    Director
    Englewood
    Westbury-On-Trym
    Bristol
    British1023130001
    BONSEY, David Anthony Yerburgh
    18 Field Close
    West Haddon
    NN6 7AB Northampton
    Director
    18 Field Close
    West Haddon
    NN6 7AB Northampton
    British12706220001
    BOURGON, Paul Andre
    611 Walpole Avenue
    H3R ZA5 Mount Royal
    Quebec
    Canada
    Director
    611 Walpole Avenue
    H3R ZA5 Mount Royal
    Quebec
    Canada
    Canadian65341180001
    BRADY, Keith James
    5 Westhill Heights
    AB32 6RY Westhill
    Aberdeenshire
    Director
    5 Westhill Heights
    AB32 6RY Westhill
    Aberdeenshire
    British63389850001
    BRADY, Keith James
    5 Westhill Heights
    AB32 6RY Westhill
    Aberdeenshire
    Director
    5 Westhill Heights
    AB32 6RY Westhill
    Aberdeenshire
    British63389850001
    BROADLEY, Stuart Richard
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Director
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    ScotlandBritish96818620001
    BROADLEY, Stuart Richard
    Invercrynoch Steading
    Maryculter
    AB12 5GX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Invercrynoch Steading
    Maryculter
    AB12 5GX Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish96818620001
    BROCKLEHURST, James Edwin
    32 Valentine Drive
    Danestone
    AB22 8YF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    32 Valentine Drive
    Danestone
    AB22 8YF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British27208990001
    BROWN, George Alexander
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Director
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish108641360001
    BROWN, Peter Edward
    78 Old School Drive
    The Oaks
    ST16 1RL Stafford
    Staffordshire
    Director
    78 Old School Drive
    The Oaks
    ST16 1RL Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish82904610002
    BUXTON, Russell David
    3 Bagworth Road
    Newbold Heath
    LE9 9NB Leicester
    Director
    3 Bagworth Road
    Newbold Heath
    LE9 9NB Leicester
    British75701160001
    BYRNE, Brian Dara
    Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    The Iceni Centre
    England
    Director
    Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    The Iceni Centre
    England
    United KingdomAmerican193205320001
    CALLENDER, Ian Alexander
    3 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    3 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish127880140001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RWG (REPAIR & OVERHAULS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Siemens Energy Global Gmbh & Co. Kg
    Otto-Hahn-Ring
    81739
    Munich
    6
    Germany
    21 sept 2020
    Otto-Hahn-Ring
    81739
    Munich
    6
    Germany
    No
    Forma jurídicaLimited Partnership
    País de registroGermany
    Autoridad legalFederal Laws Of Germany
    Lugar de registroMunich
    Número de registroHra 111200
    Buscar en el registro mercantil alemánSiemens Energy Global Gmbh & Co. Kg
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Jwg Investments Limited
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    04 may 2017
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnder The Laws Of Scotland
    Lugar de registroRegister Of Companies In Scotland
    Número de registroSc484872
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Siemens Aktiengesellschaft
    Wittelsbacherplatz
    80333
    Munich
    2
    Germany
    06 abr 2016
    Wittelsbacherplatz
    80333
    Munich
    2
    Germany
    Forma jurídicaStock Corporation
    País de registroGermany
    Autoridad legalGermany
    Lugar de registroBerlin And Munich
    Buscar en el registro mercantil alemánSiemens Aktiengesellschaft
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Wood Group Gas Turbine Services Holdings Limited
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    06 abr 2016
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroScotland
    Número de registroSc159160
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0