CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED

CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC121297
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    • (9305) /

    ¿Dónde se encuentra CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    90 St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PANALT LIMITED14 nov 198914 nov 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 25 nov 2010

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de 93 George Street Edinburgh EH2 3ES el 06 dic 2010

    2 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 4a Melville Street Edinburgh EH3 7NS el 15 mar 2010

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 20 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2010

    Estado de capital el 08 ene 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cambio de datos del director Esplanade Director Limited el 20 dic 2009

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Esplanade Secretarial Services Limited el 20 dic 2009

    2 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2009

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Ivan Anthony Goldberg el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 29 feb 2008

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 28 feb 2007

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 28 feb 2006

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro6133270
    123430250001
    GOLDBERG, Ivan Anthony
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Director
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133676040001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro6133267
    123430390001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Secretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    HARKIN, Mark James
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    Secretario
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    British42293490003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Secretario
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Secretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secretario corporativo
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    W H STENTIFORD & CO
    70-74 Cannon Street
    EC4N 6AE London
    Secretario corporativo
    70-74 Cannon Street
    EC4N 6AE London
    4247350001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    BARKLEY, John
    29 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Director
    29 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    British18955940001
    BRADLEY, Pauline Anne
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    Director
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    British34265760001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Director
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Director
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritish52710005
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish35520610001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Director
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    THOMS, Graham Storrie
    11 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QB Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    11 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QB Glasgow
    Lanarkshire
    British559690001
    TRAPP, John Fraser
    36 Bruton Street
    W1X 1DD London
    Director
    36 Bruton Street
    W1X 1DD London
    British31235900001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director corporativo
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    ¿Tiene CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 20 sept 1996
    Entregado el 08 oct 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Freehold property known as 103 portland street,manchester,greater manchester.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 oct 1996Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 05 mar 1996
    Entregado el 12 mar 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    0.299 hectares at pitreavie business park,dunfermline.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 mar 1996Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 23 ene 1996
    Entregado el 31 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descripción
    Legal mortgage over 40-54 percy street, rotherham, regsitered under title number syk 331321 and the department store being 15-21 (odd) doncaster gate, rotherham, registered under title number syk 331322, fixed charges over all builgings, goodwill, plant, etc., and a floating charge on all plant, machinery, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 19 sept 1995
    Entregado el 02 oct 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £375,000
    Breve descripción
    1) legal charge over the department store being 15 to 21 (odd) doncaster gate, rotherham and the car park being 40-54 percy street, rotherham 2) floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods relating to the legal charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Uniquegrid Limited
    Transacciones
    • 02 oct 1995Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 01 sept 1995
    Entregado el 19 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage on the carriage house, 86-88 grosvenor road and land to the east of st johns road, tunbridge wells, registered under title numbers K649270 and K666506, and other fixed charges and a floating charge....... See ch microfiche for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 sept 1995Registro de un cargo (410)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1994
    Entregado el 29 dic 1994
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    84/85 buckingham gate, westminster, registered under title number ngl 468992.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 dic 1994Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 27 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Car parking spaces 15,16 & 17 grindlay street court, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 mar 1992Registro de un cargo (410)
    • 14 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 28 feb 1992
    Entregado el 04 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    4/6 & 6A bridge street,congletch. CH393882 & CH313883.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 mar 1992Registro de una carga
    • 11 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 21 ene 1992
    Entregado el 24 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 ene 1992Registro de una carga
    • 09 oct 1995Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 18 abr 1990
    Entregado el 25 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Former buildings 1 castle terrace edinburgh 11/17 lothian road edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 abr 1990Registro de una carga
    • 14 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 15 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 18 abr 1990
    Entregado el 24 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1 castle terrace edinburgh 11/17 lothian road edinburgh.
    Personas con derecho
    • Tarmac Construction LTD
    Transacciones
    • 24 abr 1990Registro de una carga

    ¿Tiene CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 may 2012Fecha de disolución
    25 nov 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0