LAMBDA 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LAMBDA 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC122398 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LAMBDA 2 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra LAMBDA 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAMBDA 2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ND OVERSEAS UK LIMITED | 30 oct 2012 | 30 oct 2012 |
| CHRISTIAN SALVESEN FOOD SERVICES LIMITED | 02 abr 1990 | 02 abr 1990 |
| DMWS 151 LIMITED | 17 ene 1990 | 17 ene 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LAMBDA 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAMBDA 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 11 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX el 23 abr 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Georgina Garratt como secretario el 21 mar 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 31 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Georgina Garratt como director el 01 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lyndsay Gillian Navid Lane como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Georgina Garratt como secretario el 20 feb 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lyndsay Navid Lane como secretario el 17 feb 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David James Thomas como director el 04 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Gavin Evans como director el 04 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Lyndsay Navid Lane el 09 may 2016 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David James Thomas como director el 30 nov 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick Bataillard como director el 27 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gaultier De La Rochebrochard como director el 29 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Lyndsay Gillian Navid Lane como director el 14 oct 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LAMBDA 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Simon Gavin | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 150758530001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 242693040001 | |||||
| BRADLEY, John Leslie | Secretario | The Forge Wilsthorpe PE9 4PE Stamford Lincolnshire | British | 1068430001 | ||||||
| CLARK, Andrew Gerard | Secretario | 93 Queens Walk PE9 2QF Stamford Lincolnshire | British | 1244140001 | ||||||
| GARRATT, Georgina | Secretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | 225096860001 | |||||||
| HORNE, Geoffret Wemyss | Secretario | 3 Swanston Park EH10 7BR Edinburgh Midlothian | British | 52471340001 | ||||||
| LANE, Lyndsay Navid | Secretario | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7SL Northampton Xpo House England | British | 163370750001 | ||||||
| LAVELLE, James William | Secretario | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Secretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | British | 52425370006 | ||||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Secretario | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Secretario | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | British | 128431040001 | ||||||
| BATAILLARD, Patrick | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire United Kingdom | French | French | 148397660002 | |||||
| BEARD, James | Director | 5 Sharma Leas PE4 6ZH Peterborough Cambridgeshire | British | 30468010001 | ||||||
| BIRD, Richard William | Director | 68 St Mary's Lane Louth Lincolnshire | British | 26173210001 | ||||||
| BRADLEY, John Leslie | Director | The Forge Wilsthorpe PE9 4PE Stamford Lincolnshire | British | 1068430001 | ||||||
| CLARK, Andrew Gerard | Director | 93 Queens Walk PE9 2QF Stamford Lincolnshire | British | 1244140001 | ||||||
| DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier | Director | Nd House, Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 163237590002 | |||||
| FASKEN, David Robert | Director | The Coachhouse Edenside Road TD5 7BS Kelso | British | 30467940001 | ||||||
| FIDLER, Brian Harvey | Director | The Eighth House Vernon Avenue OX2 9AU Oxford | England | British | 57282470001 | |||||
| GRINDLAY, Alfred Ritchie | Director | 1 Oxford Road PE9 1BT Stamford Lincolnshire | British | 51783690003 | ||||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Director | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 66121750001 | |||||
| KING, Roy Charles | Director | Roecroft Hacconby Bourne Lincs | British | 1068450001 | ||||||
| LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 126820460002 | |||||
| LAVELLE, James William | Director | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| MACK, Christopher Charles Robert | Director | 18 Oakley Park BL1 5XL Bolton Lancashire | British | 158640001 | ||||||
| MILES, Colin Geoffrey | Director | High Bank Harlestone Road NN6 8AU Church Brampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 52425150001 | |||||
| NAVID LANE, Lyndsay Gillian | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 177674310001 | |||||
| PEGG, Paul Stephen William | Director | Holly House Weston Road, Edith Weston LE15 8HQ Oakham Leicestershire | England | British | 80197260001 | |||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Director | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| REDFERN, Paul Ian | Director | Tregartha Ryhall Road Great Casterton PE9 4AR Stamford Lincolnshire | British | 27208180002 | ||||||
| ROEBUCK, Roy | Director | Flat 7 Windermere Court Water End Thorpe Meadows PE3 6GQ Peterborough Cambridgeshire | British | 30467980001 | ||||||
| STEADMAN, Julian Alex | Director | 3 Hill Place SL2 3EW Farnham Common Buckinghamshire | United Kingdom | British | 43224360003 | |||||
| THOMAS, David James | Director | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 147800590002 | |||||
| WADDELL, John Maclaren Ogilvie | Director | 16 Kinghorn Place EH6 4BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 113233140001 | |||||
| WHEELER, Richard Neville | Director | New Hunting Court 14 Thorpe Road PE3 6 Peterborough | British | 162300001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LAMBDA 2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpo Investment Uk Limited | 06 abr 2016 | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LAMBDA 2 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0