UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC125587 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
- Actividades de consultoría de gestión que no sean gestión financiera (70229) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Ensayos y análisis técnicos (71200) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PINELAW LIMITED | 13 jun 1990 | 13 jun 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Rhys Wynne Hughes como director el 16 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruno Claudio Oliveira Teixeira como director el 23 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Innes Mackay como director el 19 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Frederic Castrec como director el 19 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Registro de la carga SC1255870002, creada el 19 ago 2022 | 20 páginas | MR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp 6 Queens Road Aberdeen Scotland AB15 4ZT Scotland a Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park Kintore Inverurie AB51 0QP el 01 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Nicholas Lanigan como secretario el 19 ago 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Nicholas Lanigan como director el 19 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Costello como secretario el 19 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Steven John Costello el 22 jul 2022 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Caroline Allen como director el 07 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Joseph Mcshane como director el 07 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Bruno Claudio Oliveira Teixeira como director el 07 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANIGAN, Philip Nicholas | Secretario | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | 299618740001 | |||||||
| CASTREC, Frederic | Director | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | France | French | 299627840001 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Director | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | England | British | 42734310002 | |||||
| MACKAY, James Innes | Director | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | Scotland | British | 108844510001 | |||||
| MCSHANE, Paul Joseph | Director | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | England | Irish | 218498550002 | |||||
| COSTELLO, Steven John | Secretario | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | 184502790001 | |||||||
| HAYHURST, Fred | Secretario | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XH Sheffield Europa View South Yorkshire United Kingdom | 159575580001 | |||||||
| MACLEOD, George Paterson | Secretario | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567150001 | ||||||
| MACLEOD, Kenneth George | Secretario | 340 Queens Road AB15 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 603660001 | ||||||
| MACLEOD, Patricia Margaret | Secretario | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567160001 | ||||||
| MIDDLETON, Sandra Elizabeth | Secretario designado | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000270001 | ||||||
| ROBINSON, Paul James | Secretario | 17 Moss Lane M33 6QD Sale Cheshire | British | 61464420001 | ||||||
| ALLEN, Caroline | Director | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | United Kingdom | British | 241814400001 | |||||
| CAREY, Malcolm Timothy | Director | 14111 Indian Wells Drive Houston Texas 77069 Usa | Usa | American | 135768760001 | |||||
| COGZELL, Matthew James | Director | Moor Gate Portishead BS20 7FL Bristol 6 United Kingdom | England | British | 157755080001 | |||||
| COWLEY, John Mitchell | Director | Hatch Place Lower Road SL6 9EJ Cookham 9 United Kingdom | England | British | 153045530001 | |||||
| DAVISON, Thomas Patrick | Director | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XE Sheffield Europa Court South Yorkshire United Kingdom | England | British | 178471340001 | |||||
| EVERETT, Alan | Director | Anfield, Balnabruach, Portmahomack IV20 1YN Tain Ross-Shire | United Kingdom | British | 91840790001 | |||||
| LAAKE, Gregory Duane | Director | 9410 Brentwood Lake Circle Spring Texas 77379 Usa | United States | United States | 104309910001 | |||||
| MACLEOD, George Paterson | Director | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567150001 | ||||||
| MACLEOD, Kathleen | Director | 340 Queens Road AB1 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 1185750001 | ||||||
| MACLEOD, Kenneth George | Director | 340 Queens Road AB15 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 603660001 | ||||||
| MACLEOD, Patricia Margaret | Director | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567160001 | ||||||
| MCNIVEN, Alan Ross | Director designado | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000280001 | ||||||
| MOKLAK, Paul Daniel | Director | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 217770510001 | |||||
| REED, JR, James Franklin | Director | Pine Arbor 77066 Houston 5419 Texas United States | Usa | United States | 137281430001 | |||||
| RHODES, Fiona Elizabeth | Director | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 200869110001 | |||||
| SMILEY, Mark Richard | Director | Bath Road SL1 3YD Slough 210 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194271890001 | |||||
| SMITH, Michael Peter | Director | Closes Hall Stump Cross Lane, Bolton By Bowland BB7 4LX Clitheroe Lancashire | British | 65426730001 | ||||||
| SOOD, Amit Kumar | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | England | British | 153181250001 | |||||
| STUBBS, Colin | Director | 1 Porterfield Bank IV2 3HL Inverness Inverness Shire | British | 100665460001 | ||||||
| STUBBS, Susan | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | United Kingdom | British | 169624400001 | |||||
| TEIXEIRA, Bruno Claudio Oliveira | Director | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | Portugal | Portuguese | 290495760001 | |||||
| WALKER, Alexander Davidson | Director | Maa-Jaa Doocot Park AB45 1DW Banff | British | 497950002 | ||||||
| WYNNE HUGHES, Adam Rhys | Director | Farrington Road BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England | England | British | 113722460001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pih Holdings Limited | 06 abr 2016 | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 19 ago 2022 Entregado el 06 sept 2022 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 dic 1992 Entregado el 29 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0