TULLOCH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TULLOCH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC125792 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TULLOCH LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TULLOCH LIMITED?
| Dirección de la sede social | Alexander Fleming House 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Morayshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TULLOCH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TULLOCH PLC | 15 dic 2003 | 15 dic 2003 |
| TULLOCH LIMITED | 21 mar 2003 | 21 mar 2003 |
| TULLOCH PLC | 24 jul 2000 | 24 jul 2000 |
| TULLOCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 04 jul 1996 | 04 jul 1996 |
| INVERNESS LIMITED | 02 ago 1994 | 02 ago 1994 |
| INVERNESS HOLDINGS LIMITED | 17 jun 1994 | 17 jun 1994 |
| TULLOCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 13 dic 1990 | 13 dic 1990 |
| TEMPLE INVESTMENTS (INVERNESS) LIMITED | 03 ago 1990 | 03 ago 1990 |
| DESIGNWHOLE LIMITED | 26 jun 1990 | 26 jun 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TULLOCH LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 may 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 28 feb 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TULLOCH LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TULLOCH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2025 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1257920010 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga SC1257920012, creada el 29 ago 2025 | 24 páginas | MR01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 10 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga SC1257920011, creada el 29 ago 2025 | 20 páginas | MR01 | ||||||||||
Modification des détails de Tulloch Homes Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 dic 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2024 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander James Grant como director el 31 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kieran Graham como director el 01 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2023 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Iain Alexander James Logan como director el 09 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michelle Hunter Motion como director el 10 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 may 2022 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 110 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2021 | 8 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 35 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TULLOCH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODD, Andrew | Secretario | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | 290283430001 | |||||||
| ADAM, Alexander William | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British | 246070480002 | |||||
| GRAHAM, Kieran | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | Scotland | Scottish | 322903410001 | |||||
| LOGAN, Iain Alexander James, Mr. | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | Scotland | British | 97626730002 | |||||
| SMITH, Innes | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | Scotland | British | 290185050001 | |||||
| CAMERON, James | Secretario | Stoneyfield House Stoneyfield Business Park IV2 7PA Inverness | British | 166635400001 | ||||||
| MCLUCAS, Donald Allan Mackintosh | Secretario | 91 Old Edinburgh Road IV2 3HT Inverness | British | 30871850001 | ||||||
| STEWART, Katherine M | Secretario | 22 Edgemoor Park Balloch IV1 2RB Inverness Inverness Shire | British | 565690001 | ||||||
| SUTHERLAND, Caroline Anne | Secretario | Slackbuie Way Fairways IV2 6AT Inverness 29 United Kingdom | British | 87534020003 | ||||||
| SUTHERLAND, Caroline Anne | Secretario | Flat 3/2, 20 Oban Drive G20 6AF Glasgow Lanarkshire | British | 67855880001 | ||||||
| SUTHERLAND, David Fraser | Secretario | Oldtown Of Leys Farm Culduthel IV2 6AE Inverness | British | 1321720003 | ||||||
| SUTHERLAND, David Fraser | Secretario | Oldtown Of Leys Farm Culduthel IV2 6AE Inverness | British | 1321720003 | ||||||
| TRACE, Marjory Bremner | Secretario | 1 Wellside Road Balloch IV2 7GS Inverness | British | 43522850004 | ||||||
| TRACE, Marjory Bremner | Secretario | 1 Wellside Road Balloch IV2 7GS Inverness | British | 43522850004 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BANKIER, Ian Patrick | Director | 2/2 168 Crow Road G11 7JS Glasgow | United Kingdom | British | 95000940001 | |||||
| BARBOUR, Theresa | Director | 16 Mcpherson Drive Bothwell G71 8QP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 127088430001 | |||||
| BARKLEY, John | Director | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||
| BRAZIER, Stephen Harvey | Director | Russett House, 8 Main Drive SL9 7PS Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 100183520001 | |||||
| CAMERON, David John | Director | Druminlochan Feshiebridge PH21 1NQ Kincraig Inverness-Shire | Scotland | British | 125212090001 | |||||
| CAMERON, Kenneth William | Director | 121 Culduthel Road IV2 4EE Inverness | Scotland | British | 41410280001 | |||||
| CAMERON, Neil Stuart | Director | 30 Overton Avenue IV3 6RR Inverness | Scotland | British | 34848670001 | |||||
| CAMERON, Neil Stuart | Director | 30 Overton Avenue IV3 6RR Inverness | Scotland | British | 34848670001 | |||||
| DUNCAN, Andrew Raymond | Director | Fearann-Nan-Gras Kilmuir, North Kessock IV1 3ZG Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 63676750001 | |||||
| FRASER, Donald Cameron | Director | 10 West Heather Road IV2 4WS Inverness | Uk | British | 154418170001 | |||||
| FRASER, George Gabriel | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | Scotland | British | 50219540001 | |||||
| FRASER, George Gabriel | Director | 7 Fairways Altonburn Road IV12 5NB Nairn Highland | Scotland | British | 50219540001 | |||||
| GRAHAM, Robert | Director | 17 Woodrush Glade Adam Brae EH54 9JY Livingston West Lothian | United Kingdom | British | 95455880001 | |||||
| GRANT, Alexander James | Director | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British | 113195780003 | |||||
| GRANT, Alexander James | Director | 52 Wester Inshes Court IV2 5HS Inverness Inverness Shire | British | 107801990001 | ||||||
| MACDONALD, Ian | Director | Stoneyfield House Stoneyfield Business Park IV2 7PA Inverness | Scotland | British | 81926330001 | |||||
| MACDONALD, Ronald Sutherland | Director | 135 Stewarton Drive G72 8DH Cambuslang | United Kingdom | British | 145418810001 | |||||
| MACDOUGALL, Alasdair | Director | 104 Culduthel Park IV2 4RZ Inverness Highland | Scotland | British | 91007550001 | |||||
| MACKENZIE, Donald Henry | Director | Taighe-Na-Coille Dalgrambich Croy IV2 5PR Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 66483050001 | |||||
| MARSHALL, Alyson | Director | 8 Blackthorn Avenue G66 4BZ Kirkintilloch Lanarkshire | Scotland | British | 116919700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TULLOCH LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulloch Homes Group Limited | 14 nov 2018 | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Tulloch Group Limited | 06 abr 2016 | Stoneyfield Business Park IV2 7PA Inverness Stoneyfield House Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0